LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06086612 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Core 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Robert Szpojnarowicz am 09. Sept. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Robert Szpojnarowicz am 02. Jan. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Christopher Robert Szpojnarowicz am 09. Sept. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Reid als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Robert Szpojnarowicz als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Robert Szpojnarowicz als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Reid als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Bennett als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Christopher Allan am 12. Okt. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Bennett als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Tonkiss als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert | Sekretär | 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | British | 175753180001 | ||||||
| ALLAN, Mark Christopher | Geschäftsführer | West End Wickwar GL12 8JZ Wotton-Under-Edge 7 Gloucestershire England | England | British | 74371010007 | |||||
| LISTER, Joseph Julian | Geschäftsführer | Cooles Farmhouse Minety SN16 9QA Malmesbury Wiltshire | United Kingdom | British | 124180960001 | |||||
| RICHARDS, Nicholas Guy | Geschäftsführer | Charterhouse Close Nailsea BS48 4PU Bristol 6 North Somerset | England | British | 122256380002 | |||||
| SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert | Geschäftsführer | 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | United Kingdom | British | 175753180001 | |||||
| REID, Andrew Donald | Sekretär | 15 Cranbrook Road Redland BS6 7BJ Bristol | British | 67884910002 | ||||||
| BENNETT, Michael Peter | Geschäftsführer | 45 Drakes Way Portishead BS20 6LD Bristol | England | British | 86546430001 | |||||
| GRANGER, James Winston Edward | Geschäftsführer | Southdale 48 Greenway Lane BA2 4LW Bath | England | British | 119802100001 | |||||
| GRANGER, James Winston Edward | Geschäftsführer | Southdale 48 Greenway Lane BA2 4LW Bath | England | British | 119802100001 | |||||
| MCDONALD, David Andrew | Geschäftsführer | Cherith Church Lane Chew Stoke BS40 8TU Bristol Avon | England | British | 67201010001 | |||||
| RATCHFORD, Martin James | Geschäftsführer | Station Road Smeeth TN25 6SY Ashford The Mill House Kent United Kingdom | England | British | 255563630001 | |||||
| REID, Andrew Donald | Geschäftsführer | 15 Cranbrook Road Redland BS6 7BJ Bristol | United Kingdom | British | 67884910002 | |||||
| TONKISS, John Michael | Geschäftsführer | The Corner House 16 The Glade B74 3NR Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 118537820001 |
Hat LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 24. März 2009 Geliefert am 03. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and each of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Okt. 2007 Geliefert am 11. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the borrowers to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H 301 holloway road london t/no NGL861556 the rental income any present and future insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Sept. 2007 Geliefert am 11. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the borrowers to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H 301 holloway road london t/no NGL861. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. März 2007 Geliefert am 03. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a 301 holloway road londo. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0