LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06137133 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PTCS 6155A LIMITED | 05. März 2007 | 05. März 2007 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 16 st Martin's Le Grand St Martins House London EC1A 4EN verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 16 st Martin's Le Grand St Martins House London EC1A 4EN geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Morton Fraser Llp St Martins House 16 st Martins Le Grand London EC1A 4EN zum 1 More London Place London SE1 2AF am 08. Jan. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 7 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Mel Zuydam als Geschäftsführer am 01. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2018 bis 30. Juni 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Mel Zuydam als Direktor am 11. Juli 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katerina Brown als Geschäftsführer am 04. Juli 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Leitch Mackenzie als Geschäftsführer am 30. Jan. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew William Lee als Geschäftsführer am 05. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Alan Walters als Geschäftsführer am 05. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 13 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 14 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mark Alan Walters als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mark Alan Walters als Direktor am 14. Dez. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Nagle als Geschäftsführer am 14. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew William Lee als Direktor am 14. Dez. 2017 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Huw Griffiths als Direktor am 14. Dez. 2017 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 2 Lister Square Quartermile Two EH3 9GL Edinburgh 5th Floor Scotland |
| 95512800001 | ||||||||||
| GRIFFITHS, David Huw | Geschäftsführer | c/o Morton Fraser Llp 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martins House | United Kingdom | British | 177733400003 | |||||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Sekretär | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | 201246720001 | |||||||||||
| BISSET, Graham Ferguson | Sekretär | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive Northamptonshire United Kingdom | 194566850001 | |||||||||||
| CALDER, Samantha Jane | Sekretär | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | British | 75830790003 | ||||||||||
| HULLEY, Christine Wyn | Sekretär | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | 35745290002 | ||||||||||
| LONG, Jacqueline | Sekretär | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive United Kingdom | 204213410001 | |||||||||||
| OLDROYD, Elizabeth Alexandra | Sekretär | 19 Middle Stoke Limpley Stoke BA2 7GF Bath | British | 98205520001 | ||||||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 294355310001 | |||||||||
| BOYD, Gordon Alexander | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | British | 148856600001 | |||||||||
| BROWN, Katerina | Geschäftsführer | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | Scotland | British | 232165890001 | |||||||||
| BUXTON, Tony Martyn | Geschäftsführer | Oaklands Somerford Road GL7 1FA Cirencester 33 Glos United Kingdom | England | British | 132588550002 | |||||||||
| FITZSIMMONS, David Stephen | Geschäftsführer | Hammer Tower Penshurst TN11 8HZ Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 109928450001 | |||||||||
| GIBBINS, Stewart Charles | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 148918290002 | |||||||||
| GREGSON, Paul Jonathan | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | British | 154908310001 | |||||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | Uk | British | 93743250007 | |||||||||
| HEWSON, John Francis | Geschäftsführer | 30 Bedford Street London WC2E 9ED | United Kingdom | British | 120308140001 | |||||||||
| HINTON, Thomas Edward | Geschäftsführer | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 238940970001 | |||||||||
| HULLEY, Christine Wyn | Geschäftsführer | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | 35745290002 | ||||||||||
| HULLEY, Stephen Paul | Geschäftsführer | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | 58163070002 | ||||||||||
| LEE, Andrew William | Geschäftsführer | c/o Morton Fraser Llp 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martins House | United Kingdom | British | 87527870001 | |||||||||
| MACHIELS, Eric Philippe Marianne | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | Belgian | 125748990002 | |||||||||
| MACKENZIE, Scott Leitch | Geschäftsführer | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | 277478140001 | |||||||||
| NAGLE, Michael | Geschäftsführer | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | 29436380007 | |||||||||
| PICKERING, Stephen Shane | Geschäftsführer | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 198076630001 | |||||||||
| QUINLAN, Rory John | Geschäftsführer | Flat 12 25 Queen's Gate Gardens South Kensington SW7 5RP London | Australian | 113941780001 | ||||||||||
| ROUND, Richard Calvin | Geschäftsführer | Elimbriar 8 Station Road Stanbridge LU7 9JF Leighton Buzzard Beds | Uk | British | 108158250002 | |||||||||
| WALTERS, Mark Alan | Geschäftsführer | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | England | British | 317548840001 | |||||||||
| ZUYDAM, David Mel | Geschäftsführer | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | England | British | 259635370001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infinis Wind Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 15. Dez. 2017 Geliefert am 29. Dez. 2017 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 09. Okt. 2013 Geliefert am 11. Okt. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Intellectual property. The chargor charges, by way of first fixed charge, all of the rights which it now has and all of the rights which it obtains at any time in the future in intellectual property.. Intellectual property means:. (A) all copyright (including rights in computer software), patents, trade marks, trade names, service marks, business names (including internet domain names), design rights, database rights, semi-conductor topography rights and all other intellectual property or similar proprietary rights (whether registered or not and including applications to register or rights to apply for registration) which, in each case, are of a type which are not disposed of in the ordinary course of trading;. (B) any intellectual property that supplements or replaces intellectual property described in (a) above; and. (C) any intellectual property acquired after the date of this deed which is designated as intellectual property by a chargor and the security agent at or about the time of its acquisition. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Nov. 2007 Geliefert am 26. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0