S&N (THI) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameS&N (THI) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06144813
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von S&N (THI) LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich S&N (THI) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von S&N (THI) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TADCASTER HOTELS & INNS LIMITED21. Mai 200721. Mai 2007
    L&P 179 LIMITED07. März 200707. März 2007

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von S&N (THI) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für S&N (THI) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für S&N (THI) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 14. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    3 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Reduce share prem a/c 03/11/2014
    RES13

    Einzelheiten zur Änderung der an Aktien geknüpften Rechte

    2 SeitenSH10

    Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse

    2 SeitenSH08

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12

    Beendigung der Bestellung von Gavin Nimmo Cameron als Geschäftsführer am 03. Nov. 2014

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Josephus Petrus Adrianus Van Der Burg als Direktor am 06. Okt. 2014

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Christopher Michael Jowsey als Direktor am 06. Okt. 2014

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr David Michael Forde als Direktor am 06. Okt. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Anne Louise Oliver als Sekretär am 06. Okt. 2014

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher John Moore am 20. März 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Gavin Nimmo Cameron am 20. März 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Anne Louise Oliver am 20. März 2014

    1 SeitenCH03

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2013 bis 31. Dez. 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2012

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Gavin Nimmo Cameron am 08. März 2013

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher John Moore am 08. März 2013

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von S&N (THI) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FORDE, David Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Geschäftsführer
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    IrelandIrish178655370001
    JOWSEY, Christopher Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Geschäftsführer
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish152505410002
    MOORE, Christopher John
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Geschäftsführer
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish136853310001
    VAN DER BURG, Josephus Petrus Adrianus
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Geschäftsführer
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandDutch167853370002
    ANSPACH, Jeffrey Alan
    Westacre
    Station Road
    YO8 3UZ Wistow
    North Yorkshire
    Sekretär
    Westacre
    Station Road
    YO8 3UZ Wistow
    North Yorkshire
    British122100770001
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Sekretär
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    British132259650001
    OLIVER, Anne Louise
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Sekretär
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    British132910690001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Sekretär
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    British80951870003
    LEE & PRIESTLEY SECRETARY LIMITED
    10-12 East Parade
    LS1 2AJ Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    10-12 East Parade
    LS1 2AJ Leeds
    West Yorkshire
    90359580001
    ANSPACH, Jeffrey Alan
    Westacre
    Station Road
    YO8 3UZ Wistow
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Westacre
    Station Road
    YO8 3UZ Wistow
    North Yorkshire
    EnglandBritish122100770001
    CAMERON, Gavin Nimmo
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Geschäftsführer
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish87163500002
    CRAWFURD-PORTER, James Justin
    Grainbeck Manor
    Ripon Road Killinghall
    HG3 2AX Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Grainbeck Manor
    Ripon Road Killinghall
    HG3 2AX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish49769230004
    CRAWSHAY, William John Julian
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    United KingdomBritish79182280001
    DRAPER, John Patrick
    The Moorlands
    Coleorton
    LE67 8GG Coalville
    75
    Leicestershire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Moorlands
    Coleorton
    LE67 8GG Coalville
    75
    Leicestershire
    United Kingdom
    British129532400001
    MACINTYRE, Donald Calum
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Ashby House
    Middlesex
    Geschäftsführer
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Ashby House
    Middlesex
    ScotlandBritish140968790001
    MACKERRON, John Charles Alexander
    2 Errington Way
    Tostock
    IP30 9PZ Bury St Edmund
    Geschäftsführer
    2 Errington Way
    Tostock
    IP30 9PZ Bury St Edmund
    British126727170001
    MCQUADE, Stephen Anthony
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    ScotlandBritish161091550001
    WALSH, James Patrick
    The Old Rectory
    Foston
    YO60 7QB York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Foston
    YO60 7QB York
    North Yorkshire
    EnglandBritish30538870002
    WOODFINE, Alison Jane
    11 Scarthingwell Park
    Barkston Ash
    LS24 9PG Tadcaster
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    11 Scarthingwell Park
    Barkston Ash
    LS24 9PG Tadcaster
    North Yorkshire
    EnglandBritish86158200001
    LEE & PRIESTLEY LIMITED
    10-12 East Parade
    LS1 2AJ Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    10-12 East Parade
    LS1 2AJ Leeds
    West Yorkshire
    93785990001

    Hat S&N (THI) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The white rose hotel 12 bedale road leeming bar. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The thorn tree public house 246 nottingham road langley mill nottingham. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The star inn main street harbottle morpeth. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The royal oak inn hirst courtney selby. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 and 3 cornmarket hill howden near goole. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The lion and swan hotel west street congleton. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The kings arm market place reeth and mews cottage reeth north yorkshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The george hotel piercebridge darlington. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The crown & anchor hotel holy island. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The cayley arms allerston and land on the west side of the cayley arms allerston near pickering north yorkshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The bridge house hotel catherick bridge richmond north yorkshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The black bull hotel reeth north yorkshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The angel inn dame lane misson doncaster. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The ancient unicorn public house and units 3,4 and 5 unicorn cottages bowes and 1 ancient union cottages bowes. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Juni 2007
    Geliefert am 23. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0