AEON INTERNATIONAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAEON INTERNATIONAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06210147
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AEON INTERNATIONAL LIMITED?

    • Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich AEON INTERNATIONAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Sky View Argosy Road
    East Midlands Airport
    DE74 2SA Castle Donington
    Derbyshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AEON INTERNATIONAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für AEON INTERNATIONAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Bestellung von Andrew Rankine Taylor als Geschäftsführer am 13. Sept. 2018

    1 SeitenTM01

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    23 SeitenLIQ14

    Beendigung der Bestellung von David Walsh als Geschäftsführer am 10. Sept. 2018

    1 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Mai 2018

    21 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Mai 2017

    22 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Mai 2016

    22 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:secretary of states certificate of release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:replacement of liquidators
    12 SeitenLIQ MISC OC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Mai 2015

    26 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Sky View Argosy Road Castle Donnington Derby DE74 2SA zum Sky View Argosy Road East Midlands Airport Castle Donington Derbyshire DE74 2SA am 17. Juli 2014

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    8 Seiten4.20

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Blenheim House Falcon Court Preston Farm Industrial Estate Stockton-on-Tees Cleveland TS18 3TS United Kingdom* am 16. Mai 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Ernennung von Mr Andrew Rankine Taylor als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr David Walsh als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Derek Watson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Robert Mc Carthy Jr als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Marek Lawniczak als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Arnaud Kerhuel als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Alan Eckford als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von AEON INTERNATIONAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WALSH, David
    Berristow Lane
    South Normanton
    DE55 2JJ Alfreton
    Radius House
    Derbyshire
    England
    Sekretär
    Berristow Lane
    South Normanton
    DE55 2JJ Alfreton
    Radius House
    Derbyshire
    England
    182774890001
    GILES, Gary
    Marmaduke Place
    TS20 1DY Stockton-On-Tees
    4
    Cleveland
    England
    Sekretär
    Marmaduke Place
    TS20 1DY Stockton-On-Tees
    4
    Cleveland
    England
    176884580001
    JONAS, Christopher Reay
    2 Vicarage Gardens
    Low Willington
    DL15 0UZ Durham
    County Durham
    Sekretär
    2 Vicarage Gardens
    Low Willington
    DL15 0UZ Durham
    County Durham
    BritishFinancial Controller126719880001
    LOWERY, Richard John Dent
    22 Windsor Crescent
    NE26 2NT Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Sekretär
    22 Windsor Crescent
    NE26 2NT Whitley Bay
    Tyne & Wear
    BritishFinance Director115481860001
    MANDERS, Steven
    Falcon Court
    Preston Farm Industrial Estate
    TS18 3TS Stockton-On-Tees
    Blenheim House
    Cleveland
    United Kingdom
    Sekretär
    Falcon Court
    Preston Farm Industrial Estate
    TS18 3TS Stockton-On-Tees
    Blenheim House
    Cleveland
    United Kingdom
    172148150001
    MENEGAS, Dean Nicholas
    1a Perrins Lane
    W1K 1QT London
    Sekretär
    1a Perrins Lane
    W1K 1QT London
    British121938390001
    WILSON, David
    Byelands Street
    TS4 2HX Middlesbrough
    9
    Cleveland
    Sekretär
    Byelands Street
    TS4 2HX Middlesbrough
    9
    Cleveland
    BritishCompany Accountant132415270001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BUYER, Jean-Paul
    Clarendon Park Road
    LE2 3AH Leicester
    95
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Clarendon Park Road
    LE2 3AH Leicester
    95
    Leicestershire
    FrenchSales And Marketing132415390001
    ECKFORD, Alan Tony
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    Geschäftsführer
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director49014470001
    KERHUEL, Arnaud
    21 Villa Santos
    Dumont 75015
    Paris
    France
    Geschäftsführer
    21 Villa Santos
    Dumont 75015
    Paris
    France
    FranceFrenchCompany Director69652820001
    KIRTON, Peter John
    Wilton Court
    Greenfields
    DL5 7PU Newton Aycliffe
    23
    Durham
    Geschäftsführer
    Wilton Court
    Greenfields
    DL5 7PU Newton Aycliffe
    23
    Durham
    United KingdomBritishTechnical128751710001
    LAWNICZAK, Marek Kazimierz
    Falcon Court
    Preston Farm Industrial Estate
    TS18 3TS Stockton-On-Tees
    Blenheim House
    Cleveland
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Falcon Court
    Preston Farm Industrial Estate
    TS18 3TS Stockton-On-Tees
    Blenheim House
    Cleveland
    United Kingdom
    PolandPolishGeneral Manager149792940001
    LOWERY, Richard John Dent
    22 Windsor Crescent
    NE26 2NT Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    22 Windsor Crescent
    NE26 2NT Whitley Bay
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishFinance Director115481860001
    MC CARTHY JR, Robert
    7 Park Square West
    NW1 4LJ London
    Geschäftsführer
    7 Park Square West
    NW1 4LJ London
    United KingdomAmericanBusinessman121938350001
    TAYLOR, Andrew Rankine
    Berristow Lane
    South Normanton
    DE55 2JJ Alfreton
    Radius House
    Derbyshire
    England
    Geschäftsführer
    Berristow Lane
    South Normanton
    DE55 2JJ Alfreton
    Radius House
    Derbyshire
    England
    United KingdomBritishCeo182780490001
    TOPPS, Martin John
    29 Green Street
    SG1 3DS Stevenage
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    29 Green Street
    SG1 3DS Stevenage
    Hertfordshire
    EnglandBritishSales & Marketing Director112393560001
    WALSH, David
    Berristow Lane
    South Normanton
    DE55 2JJ Alfreton
    Radius House
    Derbyshire
    England
    Geschäftsführer
    Berristow Lane
    South Normanton
    DE55 2JJ Alfreton
    Radius House
    Derbyshire
    England
    United KingdomBritishFinance Director182763370001
    WATSON, Derek
    68 Woodvale
    Coulby Newham
    TS8 0SJ Middlesbrough
    Cleveland
    Geschäftsführer
    68 Woodvale
    Coulby Newham
    TS8 0SJ Middlesbrough
    Cleveland
    EnglandBritishCompany Director6396340001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Hat AEON INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 13. Aug. 2009
    Geliefert am 21. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Barclays bank PLC re aeon international limited business premium account number 93509567 the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 01. Mai 2008
    Geliefert am 15. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Apr. 2007
    Geliefert am 27. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Spinnaker Capital Limited
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)

    Hat AEON INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Mai 2014Beginn der Liquidation
    04. Jan. 2019Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas John Edwards
    Sky View Argosy Road East Midlands Airport
    Castle Donington
    DE74 2SA Derby
    Derbyshire
    Praktiker
    Sky View Argosy Road East Midlands Airport
    Castle Donington
    DE74 2SA Derby
    Derbyshire
    Tyrone Courtman
    Sky View Argosy Road East Midlands Airport
    Castle Donington
    DE74 2SA Derby
    Derbyshire
    Praktiker
    Sky View Argosy Road East Midlands Airport
    Castle Donington
    DE74 2SA Derby
    Derbyshire
    Lee Brocklehurst
    Sky View Argosy Road
    East Midlands Airport
    DE74 2SA Castle Donington
    Derbyshire
    Praktiker
    Sky View Argosy Road
    East Midlands Airport
    DE74 2SA Castle Donington
    Derbyshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0