AEON INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | AEON INTERNATIONAL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 06210147 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AEON INTERNATIONAL LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich AEON INTERNATIONAL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Sky View Argosy Road East Midlands Airport DE74 2SA Castle Donington Derbyshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AEON INTERNATIONAL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AEON INTERNATIONAL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Rankine Taylor als Geschäftsführer am 13. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 23 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Walsh als Geschäftsführer am 10. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Mai 2018 | 21 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Mai 2017 | 22 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Mai 2016 | 22 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Insolvenzmeldung INSOLVENCY:secretary of states certificate of release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order INSOLVENCY:replacement of liquidators | 12 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Mai 2015 | 26 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Sky View Argosy Road Castle Donnington Derby DE74 2SA zum Sky View Argosy Road East Midlands Airport Castle Donington Derbyshire DE74 2SA am 17. Juli 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 8 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 3 Seiten | F10.2 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Blenheim House Falcon Court Preston Farm Industrial Estate Stockton-on-Tees Cleveland TS18 3TS United Kingdom* am 16. Mai 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Rankine Taylor als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Walsh als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Derek Watson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Mc Carthy Jr als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marek Lawniczak als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Arnaud Kerhuel als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Eckford als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AEON INTERNATIONAL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALSH, David | Sekretär | Berristow Lane South Normanton DE55 2JJ Alfreton Radius House Derbyshire England | 182774890001 | |||||||
GILES, Gary | Sekretär | Marmaduke Place TS20 1DY Stockton-On-Tees 4 Cleveland England | 176884580001 | |||||||
JONAS, Christopher Reay | Sekretär | 2 Vicarage Gardens Low Willington DL15 0UZ Durham County Durham | British | Financial Controller | 126719880001 | |||||
LOWERY, Richard John Dent | Sekretär | 22 Windsor Crescent NE26 2NT Whitley Bay Tyne & Wear | British | Finance Director | 115481860001 | |||||
MANDERS, Steven | Sekretär | Falcon Court Preston Farm Industrial Estate TS18 3TS Stockton-On-Tees Blenheim House Cleveland United Kingdom | 172148150001 | |||||||
MENEGAS, Dean Nicholas | Sekretär | 1a Perrins Lane W1K 1QT London | British | 121938390001 | ||||||
WILSON, David | Sekretär | Byelands Street TS4 2HX Middlesbrough 9 Cleveland | British | Company Accountant | 132415270001 | |||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
BUYER, Jean-Paul | Geschäftsführer | Clarendon Park Road LE2 3AH Leicester 95 Leicestershire | French | Sales And Marketing | 132415390001 | |||||
ECKFORD, Alan Tony | Geschäftsführer | 53 Temple Mill Island Bisham SL7 1SQ Marlow Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 49014470001 | ||||
KERHUEL, Arnaud | Geschäftsführer | 21 Villa Santos Dumont 75015 Paris France | France | French | Company Director | 69652820001 | ||||
KIRTON, Peter John | Geschäftsführer | Wilton Court Greenfields DL5 7PU Newton Aycliffe 23 Durham | United Kingdom | British | Technical | 128751710001 | ||||
LAWNICZAK, Marek Kazimierz | Geschäftsführer | Falcon Court Preston Farm Industrial Estate TS18 3TS Stockton-On-Tees Blenheim House Cleveland United Kingdom | Poland | Polish | General Manager | 149792940001 | ||||
LOWERY, Richard John Dent | Geschäftsführer | 22 Windsor Crescent NE26 2NT Whitley Bay Tyne & Wear | United Kingdom | British | Finance Director | 115481860001 | ||||
MC CARTHY JR, Robert | Geschäftsführer | 7 Park Square West NW1 4LJ London | United Kingdom | American | Businessman | 121938350001 | ||||
TAYLOR, Andrew Rankine | Geschäftsführer | Berristow Lane South Normanton DE55 2JJ Alfreton Radius House Derbyshire England | United Kingdom | British | Ceo | 182780490001 | ||||
TOPPS, Martin John | Geschäftsführer | 29 Green Street SG1 3DS Stevenage Hertfordshire | England | British | Sales & Marketing Director | 112393560001 | ||||
WALSH, David | Geschäftsführer | Berristow Lane South Normanton DE55 2JJ Alfreton Radius House Derbyshire England | United Kingdom | British | Finance Director | 182763370001 | ||||
WATSON, Derek | Geschäftsführer | 68 Woodvale Coulby Newham TS8 0SJ Middlesbrough Cleveland | England | British | Company Director | 6396340001 | ||||
WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Hat AEON INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge over credit balances | Erstellt am 13. Aug. 2009 Geliefert am 21. Aug. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Barclays bank PLC re aeon international limited business premium account number 93509567 the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Mai 2008 Geliefert am 15. Mai 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Apr. 2007 Geliefert am 27. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat AEON INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0