VINCI ENVIRONMENT UK LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VINCI ENVIRONMENT UK LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06248053 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VINCI ENVIRONMENT UK LIMITED?
- Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten n.a. (43999) / Bauwesen
Wo befindet sich VINCI ENVIRONMENT UK LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Astral House, Imperial Way Watford WD24 4WW Hertfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VINCI ENVIRONMENT UK LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für VINCI ENVIRONMENT UK LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
|---|---|
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 14. Mai 2024 |
Welche sind die letzten Einreichungen für VINCI ENVIRONMENT UK LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Aug. 2024
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Mai 2024 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julian Paul Gatward als Geschäftsführer am 19. Apr. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Yanick Garillon als Geschäftsführer am 30. Juni 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Cessation of Vinci Environnement as a person with significant control on 10. Mai 2023 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Vinci Construction Grands Projets as a person with significant control on 10. Mai 2023 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Pierre Joseph Bourgeois als Direktor am 01. Juli 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Scott Alexander Wardrop als Direktor am 30. Nov. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Julien Rayssiguier als Direktor am 29. Nov. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Yanick Garillon als Direktor am 29. Nov. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Luc Valaize als Geschäftsführer am 29. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hughes Guy Marie Patrick Seutin als Geschäftsführer am 30. Okt. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francois De Gassart als Geschäftsführer am 30. Okt. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Fernando Sistac als Geschäftsführer am 30. Aug. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gilles Bruno Marie Godard als Geschäftsführer am 30. Sept. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VINCI ENVIRONMENT UK LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURGEOIS, Pierre Joseph | Geschäftsführer | Boulevard De La Defense 92000 Nanterre 1973 France | France | French | 311724140001 | |||||
| RAYSSIGUIER, Julien | Geschäftsführer | Boulevard De La Defense 92000 Nanterre 1973 France | France | French | 302993560001 | |||||
| WARDROP, Scott Alexander | Geschäftsführer | Springfield Road RH12 2RW Horsham Albion House England | England | British | 60380650003 | |||||
| BONNET, Jean-Pierre | Sekretär | Imperial Way WD24 4WW Watford Astral House Hertfordshire United Kingdom | British | 194183130001 | ||||||
| BOWLER, David William | Sekretär | 34 Dorset Square NW1 6QJ London | British | 34940010005 | ||||||
| COMBA, Alexander Michael | Sekretär | 136 Andrewes House Barbican EC2Y 8BA London | British | 5466420005 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BERGIN, John Christopher | Geschäftsführer | Barnshaw Lodge Goostrey Lane CW4 8BH Twemlow Green Cheshire | British | 52918060002 | ||||||
| COMBA, Alexander Michael | Geschäftsführer | 136 Andrewes House Barbican EC2Y 8BA London | England | British | 5466420005 | |||||
| DUPETY, Bruno Michel | Geschäftsführer | Marylebone High Street W1U 4QW London 82 United Kingdom | United Kingdom | French | 160566530006 | |||||
| GARILLON, Yanick | Geschäftsführer | Boulevard De La Defense 92000 Nanterre 1973 France | France | French | 302993310001 | |||||
| GASSART, Francois De | Geschäftsführer | Boulevard Franklin Roosevelt 92500 Rueil-Malmaison 89 France | France | French | 242539510001 | |||||
| GATWARD, Julian Paul | Geschäftsführer | Imperial Way WD24 4WW Watford Astral House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 192754090002 | |||||
| GEFFIN, Michael | Geschäftsführer | 26 Towers Road HA5 4SJ Pinner Middlesex | British | 113983250001 | ||||||
| GODARD, Gilles Bruno Marie | Geschäftsführer | 9 Place De L'Europe 92851 Rueil-Malmaison Cedex Vinci Construction International France | England | French | 268244220001 | |||||
| HAEGEL, Didier | Geschäftsführer | 2 Allee Ds Mevauges Chaton 78400 France | France | French | 139040700001 | |||||
| HOUGHTON, Marc | Geschäftsführer | 89 Boulevard Franklin Roosevelt Rueil-Malmaison Cedex 92506 France | France | British | 205452350001 | |||||
| MATLINGER, Geoffrey | Geschäftsführer | Boulevard Franklin Roosevelt 92500 Rueil-Malmaison 89 France | France | French | 232699730001 | |||||
| MAYO, Gary William | Geschäftsführer | Imperial Way WD24 4WW Watford Astral House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 130905160001 | |||||
| MEND BOURE, Alain Jean | Geschäftsführer | 21 Av Charles Gagny 93220 France | French | 126709690001 | ||||||
| PEIGNE, Frederic Yves Marie | Geschäftsführer | Boulevard Frankilin Roosevelt 92500 Rueil-Malmaison 89 France | France | French | 217342600001 | |||||
| SEUTIN, Hughes Guy Marie Patrick | Geschäftsführer | 16b Rue Pottier Le Chesnay 78150 France | France | Belgian | 126709620001 | |||||
| SISTAC, Fernando | Geschäftsführer | 165 Boulevard De Valmy Colombes 92700 France | France | French | 266328950001 | |||||
| SNEED, Helene Annick Madeleine | Geschäftsführer | 27 Rue De Satory Versailles 78000 France | France | French | 126709020001 | |||||
| STANLEY, Graham | Geschäftsführer | Swallowfield Street Swallowfield RG7 1QX Reading Northcote Berkshire | United Kingdom | British | 136362360001 | |||||
| STUBLER, Jerome Maurice | Geschäftsführer | 5 Cours Ferdinand-De-Lesseps Rueil-Malmaison Cedex Vinci Construction 92851 France | France | French | 261904890001 | |||||
| THORNEYCROFT, Leslie Colin | Geschäftsführer | The Spires Queens Road ME16 0JE Maidstone 7 Kent | United Kingdom | British | 139040520001 | |||||
| TRINQUARD, Thierry | Geschäftsführer | 10 Av Alfred De Musset Montesson 78360 France | France | French | 126709580001 | |||||
| VALAIZE, Luc | Geschäftsführer | Boulevard Franklin Roosevelt 92500 Rueil-Malmaison 89 France | France | French | 242539250001 | |||||
| WILLIAMS, David | Geschäftsführer | 11 The Orchards Eaton Bray LU6 2DD Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | 126918330001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei VINCI ENVIRONMENT UK LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinci Construction Grands Projets | 10. Mai 2023 | Boulevard De La Défense 92000 Nanterre 1973 France | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Vinci Environnement | 06. Apr. 2016 | Cours Ferdinand De Lesseps 92851 Rueil-Malmaison 1 France | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Vinci Construction Uk Limited | 06. Apr. 2016 | Imperial Way WD24 4WW Watford Astral House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0