OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED

OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOWEN PUGH PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06252475
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4 Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NORHAM HOUSE 1116 LIMITED18. Mai 200718. Mai 2007

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    24 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    26 SeitenAM10

    Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt

    12 SeitenAM16

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    29 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    14 SeitenAM10

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    3 SeitenAM06

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    9 SeitenAM02

    Vorschlag des Verwalters

    20 SeitenAM03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Cramlington Road Dudley Cramlington Northumberland NE23 7PR zum 4 Hardman Square Manchester M3 3EB am 27. Okt. 2017

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    3 SeitenAM01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Robin Scott Armstrong am 06. Okt. 2017

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Rae Grant als Geschäftsführer am 29. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Eintragung der Belastung 062524750010, erstellt am 28. Juli 2017

    45 SeitenMR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Katherine Anne Dickie am 08. Mai 2017

    1 SeitenCH03

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Alan Park als Direktor am 18. Mai 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Richard John Dent Lowery als Geschäftsführer am 18. Mai 2017

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    19 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 062524750009, erstellt am 11. Nov. 2016

    8 SeitenMR01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 15. Juni 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Ernennung von Mr Richard John Dent Lowery als Direktor am 01. Apr. 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 20. Mai 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    APPLEGARTH, Katherine Anne
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    England
    Sekretär
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    England
    British181186620002
    ARMSTRONG, Robin Scott
    Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    4
    Geschäftsführer
    Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish135000980002
    DICKSON, John Raymond
    The Farmhouse
    West Marlish
    NE61 4ER Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    The Farmhouse
    West Marlish
    NE61 4ER Morpeth
    Northumberland
    EnglandBritish108398500001
    PARK, Alan
    Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    4
    Geschäftsführer
    Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritish231749470001
    DICKSON, John Raymond
    The Farmhouse
    West Marlish
    NE61 4ER Morpeth
    Northumberland
    Sekretär
    The Farmhouse
    West Marlish
    NE61 4ER Morpeth
    Northumberland
    British108398500001
    DIXON, Keith
    4 Enfield Avenue
    Swalwell
    NE16 3EE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    4 Enfield Avenue
    Swalwell
    NE16 3EE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British1692810001
    NORHAM HOUSE SECRETARY LIMITED
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne &Wear
    Sekretär
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne &Wear
    101749170001
    DIXON, Keith
    4 Enfield Avenue
    Swalwell
    NE16 3EE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    4 Enfield Avenue
    Swalwell
    NE16 3EE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British1692810001
    GRANT, Jonathan Rae
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    United KingdomBritish196766100001
    LOWERY, Richard John Dent
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    United KingdomBritish115481860001
    ROBINSON, Sally
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    EnglandBritish159156020001
    SAMUEL, Peter Bell
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    EnglandBritish104237060001
    WHITE, Grahame
    3 Ripon Close
    Barns Park
    NE23 7XJ Cramlington
    Northumberland
    Geschäftsführer
    3 Ripon Close
    Barns Park
    NE23 7XJ Cramlington
    Northumberland
    EnglandBritish96977240001
    NORHAM HOUSE DIRECTOR LIMITED
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    101749130001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Dudley
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Dudley
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer05314796
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 28. Juli 2017
    Geliefert am 03. Aug. 2017
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Merino Industries LTD (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 11. Nov. 2016
    Geliefert am 11. Nov. 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Freehold property known as land & buildings known as 1&2 rowlands buildings, dudley, cramlington registered at h m land registry with title numbers TY478703 and TY523755 together with such right, title and interest as the company may have in the land shaded green in the plan attached to the mortgage instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Nov. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 11. Nov. 2013
    Geliefert am 13. Nov. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    F/H property at factory road blaydon t/no TY59819. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Sept. 2010
    Geliefert am 23. Sept. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from owen pugh holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Miners welfare site cramlington road dudley northumberland t/no TY468284; with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Apr. 2008
    Geliefert am 26. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from owen pugh holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a shibdon business centre blaydon tyne and wear with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Apr. 2008
    Geliefert am 18. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from owen pugh holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the south & east of rowlands buildings, dudley and land to the south & east of victory cottages, dudley t/n's TY286788 & TY395351 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Feb. 2008
    Geliefert am 21. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Feb. 2008
    Geliefert am 21. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from owen pugh holdings limited to the chargee on any account whatosever
    Kurze Angaben
    Land at bassington industrial estate cramlington t/no ND154134 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Feb. 2008
    Geliefert am 21. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land lying to the south and east of rowlands buildings and land lying to the south and east of victory cottages dudley t/no TY286788 and TY395351 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Feb. 2008
    Geliefert am 21. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from owen pugh holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at cramlington road and lying to the west of west view dudley cramlington t/no's TY440277 and TY445741.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)

    Hat OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Okt. 2017Beginn der Verwaltung
    19. Sept. 2019Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Christopher Petts
    2nd Floor Rotterdam House 116 Quayside
    NE1 3DY Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    2nd Floor Rotterdam House 116 Quayside
    NE1 3DY Newcastle Upon Tyne

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0