BITE SIZE PORTFOLIO (NOMINEE) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BITE SIZE PORTFOLIO (NOMINEE) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06277950 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BITE SIZE PORTFOLIO (NOMINEE) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich BITE SIZE PORTFOLIO (NOMINEE) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Seebeck House 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Buckinghamshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BITE SIZE PORTFOLIO (NOMINEE) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BITE SIZE PORTFOLIO (GP2) LIMITED | 18. Juli 2007 | 18. Juli 2007 |
| SECKLOE 345 LIMITED | 13. Juni 2007 | 13. Juni 2007 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BITE SIZE PORTFOLIO (NOMINEE) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BITE SIZE PORTFOLIO (NOMINEE) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ashley John Wilcox als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edward Henson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Whiteley als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Edward Guy Henson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 062779500006 | 19 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Andrew Richard Whiteley als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Lakeside Shirwell Crescent Furzton Milton Keynes Buckinghamshire MK4 1GA* am 09. Feb. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hotbed Directors Two Limited als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hotbed Directors One Limited als Geschäftsführer | 3 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BITE SIZE PORTFOLIO (NOMINEE) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | One Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire | 93910510021 | |||||||||||
| WILCOX, Ashley John | Geschäftsführer | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 161790320001 | |||||||||
| DALE, Bernard John | Geschäftsführer | Clyde House 23 Westgate NG25 0JN Southwell Nottinghamshire | England | British | 106438400001 | |||||||||
| HAWKES, Peter Michael | Geschäftsführer | Segraves Boxworth CB23 4LS Cambridge 7 Cambridgeshire United Kingdom | England | English | 11768200002 | |||||||||
| HENSON, Edward Guy | Geschäftsführer | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 160163540001 | |||||||||
| LAUBER, Mark Karl | Geschäftsführer | Shirwell Crescent Furzton MK4 1GA Milton Keynes Lakeside Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 11449350002 | |||||||||
| MADDEN, Claire Estelle | Geschäftsführer | The Cottage Crowfield NN13 5TW Brackley Northamptonshire | United Kingdom | British | 78061950003 | |||||||||
| MARKHAM, Jonathan | Geschäftsführer | 17 Priory Villas Colney Hatch Lane N11 3DB London | United Kingdom | British | 83335420002 | |||||||||
| ROBINS, Gary John | Geschäftsführer | Lakeside Shirwell Crescent MK4 1GA Furzton Milton Keynes Buckinghamshire | England | British | 155402600001 | |||||||||
| ROBINS, Gary John | Geschäftsführer | Thornton Hall MK17 0HB Thornton Orchard House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 155402600001 | |||||||||
| TAYLOR, Andrew | Geschäftsführer | 8 Waine Close MK18 1FG Buckingham Buckinghamshire | British | 116537960001 | ||||||||||
| WHITELEY, Andrew Richard | Geschäftsführer | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 160673500001 | |||||||||
| ZANT-BOER, Ian | Geschäftsführer | c/o Emw Picton Howell Llp Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House 1 Buckinghamshire | United Kingdom | British | 222303310002 | |||||||||
| EMW DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Seckloe House 101 North 13th Street MK9 3NX Central Milton Keynes Buckinghamshire | 97336730001 | |||||||||||
| HOTBED DIRECTORS ONE LIMITED | Geschäftsführer | Shirwell Crescent Furzton MK4 1GA Milton Keynes Lakeside Buckinghamshire United Kingdom |
| 165106520001 | ||||||||||
| HOTBED DIRECTORS TWO LIMITED | Geschäftsführer | Shirwell Crescent Furzton MK4 1GA Milton Keynes Lakeside Buckinghamshire United Kingdom |
| 165106530001 |
Hat BITE SIZE PORTFOLIO (NOMINEE) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 01. Mai 2013 Geliefert am 16. Mai 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Apr. 2009 Geliefert am 09. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H premises at standing way, redmoor, milton keynes t/n BM263332 and all buildings and fixtures see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rents | Erstellt am 03. März 2008 Geliefert am 05. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Whole right title and interest in and to the rent and all other monies see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Nov. 2007 Geliefert am 01. Dez. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property being land lying to the south of standing way redmoor (t/no BM26333. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Nov. 2007 Geliefert am 28. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property being unit 1A meadowbrook park industrial estate station road sheffield t/no SYK454936 and land on the north west side of meadowbrook park holbrook. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 26TH november 2007 and | Erstellt am 13. Nov. 2007 Geliefert am 05. Dez. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All those subjects at rowallan business park,southcraig ave,kilmarnock; t/no AYR3588. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0