MUSTO TOPCO LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MUSTO TOPCO LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06295516 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MUSTO TOPCO LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MUSTO TOPCO LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | International House St Katharine Docks St. Katharines Way E1W 1UN London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MUSTO TOPCO LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DE FACTO 1507 LIMITED | 27. Juni 2007 | 27. Juni 2007 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MUSTO TOPCO LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für MUSTO TOPCO LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 30. Juni 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 14. Juli 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 30. Juni 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für MUSTO TOPCO LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2025 mit Aktualisierungen | 11 Seiten | CS01 | ||||||||||
Cessation of Helly Hansen Holding As as a person with significant control on 31. Mai 2025 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Kontoor Brands, Inc. as a person with significant control on 01. Juni 2025 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 22. Mai 2025
| 8 Seiten | SH01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Sept. 2024 mit Aktualisierungen | 11 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jean-Philippe Arcand als Geschäftsführer am 16. Aug. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Piers Sheldon Barnes am 01. Jan. 2024 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 27. Dez. 2023
| 8 Seiten | SH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Sept. 2023 mit Aktualisierungen | 9 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Sept. 2022 mit Aktualisierungen | 9 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Michael Brook als Direktor am 28. Jan. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jean-Philippe Arcand als Direktor am 28. Jan. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mahes Wickramasinghe als Geschäftsführer am 16. Sept. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Herbert Stoneham als Geschäftsführer am 16. Sept. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Wilhelm Matheson als Geschäftsführer am 28. Feb. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Sept. 2021 mit Aktualisierungen | 9 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Sept. 2020 mit Aktualisierungen | 9 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MUSTO TOPCO LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOK, James Michael | Sekretär | St Katharine Docks St. Katharines Way E1W 1UN London International House England | 248520510001 | |||||||
| BARNES, Piers Sheldon | Geschäftsführer | c/o Helly Hansen Uk Ltd Colliers Way NG8 6AT Nottingham G3a, Birkbeck House England | England | British | 82152360004 | |||||
| BROOK, James Michael | Geschäftsführer | St Katharine Docks St. Katharines Way E1W 1UN London International House England | England | British | 294986370001 | |||||
| BROOK, James Michael | Sekretär | St Katharine Docks St. Katharines Way E1W 1UN London International House England | 234811970001 | |||||||
| COOK, David Robert | Sekretär | Juniper West, Fenton Way SS15 6SJ Basildon Unit 4 Essex England | British | 205194920001 | ||||||
| DEAKIN, Andrew David | Sekretär | Flat 7 106 Felsham Road SW15 1DQ London | British | 103587650002 | ||||||
| MANNING, Anthony | Sekretär | 62 Empress Avenue IG8 9EA Woodford Green Essex | British | 98897960001 | ||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 38590450001 | |||||||
| ADAMS, David Alexander Robertson | Geschäftsführer | Juniper West, Fenton Way SS15 6SJ Basildon Unit 4 Essex England | England | British | 55757700003 | |||||
| ARCAND, Jean-Philippe | Geschäftsführer | St Katharine Docks St. Katharines Way E1W 1UN London International House England | Norway | Canadian | 294985980001 | |||||
| BURNS, David | Geschäftsführer | 32 Festing Road SW15 1LP London | England | British | 67605640001 | |||||
| CALAM, Duncan Richard | Geschäftsführer | St Katharine Docks St. Katharines Way E1W 1UN London International House England | England | British | 121314190001 | |||||
| COOK, David Robert | Geschäftsführer | Juniper West, Fenton Way SS15 6SJ Basildon Unit 4 Essex England | United Kingdom | British | 205194920001 | |||||
| DEAKIN, Andrew David | Geschäftsführer | Flat 7 106 Felsham Road SW15 1DQ London | United Kingdom | British | 103587650002 | |||||
| LEE, Simon Timothy | Geschäftsführer | St Katharine Docks St. Katharines Way E1W 1UN London International House England | England | British | 196796300001 | |||||
| LENON, Philip Hugh | Geschäftsführer | St Katharine Docks St. Katharines Way E1W 1UN London International House England | United Kingdom | British | 157995280001 | |||||
| MANNING, Anthony | Geschäftsführer | 62 Empress Avenue IG8 9EA Woodford Green Essex | United Kingdom | British | 98897960001 | |||||
| MATHESON, Wilhelm | Geschäftsführer | Munkedamsveien 0250 Oslo 35 Norway | Norway | Norwegian | 196460300001 | |||||
| MUSTO, Franklyn Keith | Geschäftsführer | 37 High Street CM0 8AG Burnham On Crouch Essex | United Kingdom | British | 26350100003 | |||||
| MUSTO, Nigel | Geschäftsführer | Ulting Hall Road CM9 6QR Ulting Ulting Hall Essex | United Kingdom | British | 124038350004 | |||||
| PEACE, John, Sir | Geschäftsführer | St Katharine Docks St. Katharines Way E1W 1UN London International House England | England | British | 220812220001 | |||||
| PEACE, John Wilfred | Geschäftsführer | Horseferry Road SW1P 2AW London Horseferry House | United Kingdom | British | 2895480002 | |||||
| PEACE-GADSBY, Alexandra Elizabeth | Geschäftsführer | St Katharine Docks St. Katharines Way E1W 1UN London International House England | United Kingdom | British | 170242530001 | |||||
| SMITH, Peter Anthony | Geschäftsführer | St Katharine Docks St. Katharines Way E1W 1UN London International House England | England | British | 163500250002 | |||||
| STONEHAM, Paul Herbert | Geschäftsführer | Munkedamsveien 0250 Oslo 35 Norway | United Kingdom | Canadian/British/Usa | 239831180001 | |||||
| TOWNE, Andrew John | Geschäftsführer | 106 Prestbury Road SK10 3BN Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 127421390001 | |||||
| WICKRAMASINGHE, Mahes | Geschäftsführer | St. Katharines Way E1W 1UN London International House England | Canada | Canadian | 258238600001 | |||||
| TRAVERS SMITH DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 116109440001 | |||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 38590450001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MUSTO TOPCO LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoor Brands, Inc. | 01. Juni 2025 | Suite 550 Raleigh 2626 Glenwood Avenue Nc 27608 United States | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Helly Hansen Holding As | 01. Nov. 2017 | 6fl N-0250 Oslo Munkedamsvelen 35 Norway | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Phoenix Equity Nominees Limited | 06. Apr. 2016 | 25 Bedford Street WC2E 9ES London 3rd Floor England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Sir John Peace | 06. Apr. 2016 | Manor Road Caunton NG23 6AD Newark Caunton Manor Nottinghamshire England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Phoenix Equity Partners Guernsey 2006 Limited | 06. Apr. 2016 | Royal Avenue St. Peter Port GY1 1HL Guernsey 1 Royal Plaza Guernsey | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0