2OC (HOLDINGS) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | 2OC (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 06300204 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
- Tätigkeit von Holdinggesellschaften für die Produktion (64202) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Bank Gallery High Street CV8 1LY Kenilworth England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BLUE-NG (HOLDINGS) LIMITED | 26. Sept. 2007 | 26. Sept. 2007 |
INTERCEDE 2195 LIMITED | 03. Juli 2007 | 03. Juli 2007 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Suite 5B 2nd Floor 1-9 Castle Street Hinckley Leicestershire LE10 1DA United Kingdom zum Bank Gallery High Street Kenilworth CV8 1LY am 12. Jan. 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for 2Oc Ltd as a person with significant control on 01. Mai 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 2 Temple Back East Temple Quay Bristol England BS1 6EG zum Suite 5B 2nd Floor 1-9 Castle Street Hinckley Leicestershire LE10 1DA am 07. Mai 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Feb. 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Mitchell als Geschäftsführer am 13. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 26. Apr. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Feb. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Philip Green als Geschäftsführer am 31. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ernest Ronald Oxburgh als Geschäftsführer am 31. März 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ovalsec Limited als Sekretär am 30. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REINHEIMER-JONES, Philip | Geschäftsführer | Lower Bond Street LE10 1QU Hinckley Atkins Building United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 177046520001 | ||||||||
DURRANT, Andrew Peter | Sekretär | 340 Sidegate Lane IP4 3DW Ipswich Suffolk | British | 85381310004 | ||||||||||
FORWARD, David Charles | Sekretär | Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol 2 England England | British | 26385930010 | ||||||||||
GREEN, Richard Philip | Sekretär | Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol 2 | British | 162243360001 | ||||||||||
MITRE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||||||
OVALSEC LIMITED | Sekretär | Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol 2 |
| 149653060001 | ||||||||||
ASTLE, Edward Morrison | Geschäftsführer | Bailey Farmhouse Chatham Green, Little Waltham CM3 3LE Chelmsford Essex | United Kingdom | British | Company Director | 68674100002 | ||||||||
COCHRANE, John Gregory | Geschäftsführer | 1-3 Strand London WC2N 5EH | American | Executive Vice President | 124590170001 | |||||||||
GREEN, Richard Philip | Geschäftsführer | Lower Bond Street LE10 1QU Hinckley Atkins Building United Kingdom | England | British | Accountant | 58023250002 | ||||||||
MAYHEW, George Philip Angus | Geschäftsführer | 1 Rookery Cottages The Street GU10 3DU Frensham Surrey | British | Director Of Corporate Affairs | 124744520001 | |||||||||
MITCHELL, Nigel | Geschäftsführer | Lower Bond Street LE10 1QU Hinckley Atkins Building United Kingdom | England | British | Company Director | 43097880001 | ||||||||
OXBURGH, Ernest Ronald, Lord | Geschäftsführer | Lower Bond Street LE10 1QU Hinckley Atkins Building United Kingdom | England | British | Retired | 116247330001 | ||||||||
SCOTT, Jeffrey Alan | Geschäftsführer | Strand WC2N 5EH London 1-3 | Uk | British | Engineer | 148649200001 | ||||||||
WATERS, Christopher John | Geschäftsführer | Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol 2 England England | United Kingdom | British | Accountant | 133752200002 | ||||||||
WOOD, Alison Jane | Geschäftsführer | 1-3 Strand London WC2N 5EH | United Kingdom | British | Global Director Of Business Development And Strate | 131902120001 | ||||||||
MITRE DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900024450001 | |||||||||||
MITRE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900027570001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei 2OC (HOLDINGS) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2oc Ltd | 06. Apr. 2016 | 1-9 Castle Street LE10 1DA Hinckley Suite 5b 2nd Floor Leicestershire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat 2OC (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Account charge | Erstellt am 27. März 2013 Geliefert am 10. Apr. 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Charged property meaning all assets subject of the security interests created by the 2OC account charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Agreement | Erstellt am 14. März 2013 Geliefert am 23. März 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The agreement and by way of security to secure the performance of the vendor's obligations under clause 14 of the agreement the vendor has irrevocable appointed the purchasers as its attorney to execute any and all documents instruments and proxies which the purchasers may in their absolute and unfettered discretion require to enable the purchasers to exercise all voting and other rights attaching to the relevant debt and relevant shares. Shares means 3,600,000 issued fullypaid ordinary shres of £1 each in the capital of the company comprising 90 per cent of the issued share capital of the company at completion see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Okt. 2012 Geliefert am 09. Okt. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company 20C (UK) limited and 20C limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Okt. 2012 Geliefert am 09. Okt. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company 20C (UK) limited and 20C limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over securities | Erstellt am 25. Sept. 2007 Geliefert am 05. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as intercede 2195 limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All securities and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0