KBC BECKENHAM LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KBC BECKENHAM LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06341889 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KBC BECKENHAM LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich KBC BECKENHAM LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 6th Floor, 2 Kingdom Street W2 6BD London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KBC BECKENHAM LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KBC BECKENHAM LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Burwood Place London W2 2UT England zum 6th Floor, 2 Kingdom Street London W2 6BD am 14. Aug. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Simon Oliver Loh als Geschäftsführer am 12. Mai 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 2 Seiten | AA | ||
Eintragung der Belastung 063418890007, erstellt am 31. Dez. 2020 | 32 Seiten | MR01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 17 Seiten | AA | ||
Eintragung der Belastung 063418890006, erstellt am 20. Okt. 2020 | 4 Seiten | MR01 | ||
Ernennung von Mr Simon Oliver Loh als Direktor am 06. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Peter David Edward Gibson als Geschäftsführer am 28. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 16 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 16 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2016 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 268 Bath Road Slough SL1 4DX zum 1 Burwood Place London W2 2UT am 14. Okt. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Alan Douglas Pepper als Geschäftsführer am 09. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von KBC BECKENHAM LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRIS, Richard | Geschäftsführer | 2 Kingdom Street W2 6BD London 6th Floor, England | England | British | 190653350001 | |||||
| ALEXANDER, Paul | Sekretär | c/o C/O Serviced Office Group Long Acre WC2E 9LY London 22 England | 183163730001 | |||||||
| CLAGUE, Stephen James Taylor | Sekretär | 72 Shinfield Road RG2 7DA Reading Berkshire | British | 73690140002 | ||||||
| EDWARDS, Marie Elizabeth | Sekretär | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | 185429200001 | |||||||
| SCANNELL, Elizabeth Jane | Sekretär | Fleet House 8-12 New Bridge Street EC4V 6AL London | 152163970002 | |||||||
| ALEXANDER, Paul Andrew | Geschäftsführer | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | England | British | 97550550001 | |||||
| CLAGUE, Stephen James Taylor | Geschäftsführer | 72 Shinfield Road RG2 7DA Reading Berkshire | United Kingdom | British | 73690140002 | |||||
| CORPET, Antoine | Geschäftsführer | Limburg Road SW11 1HB London 36 England | French | 131276650001 | ||||||
| GIBSON, Peter David Edward | Geschäftsführer | Burwood Place W2 2UT London 1 England | Northern Ireland | British | 139640170001 | |||||
| HILL, Nicholas Mark Lalor | Geschäftsführer | 36 Hazlewell Road SW15 6LR London | United Kingdom | British | 76547250001 | |||||
| KINGSHOTT, Michael James | Geschäftsführer | Long Acre WC2E 9LY London 22 England | United Kingdom | British | 83713020001 | |||||
| LOH, Simon Oliver | Geschäftsführer | Burwood Place W2 2UT London 1 England | United Kingdom | British | 197301770002 | |||||
| PEPPER, Alan Douglas | Geschäftsführer | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | England | British | 98245120002 | |||||
| PETRIE, Roderick Mckenzie | Geschäftsführer | Clashfarquhar 37 Kings Road EH32 0NN Longniddry East Lothian | Scotland | British | 1246700004 | |||||
| ROWBOTTOM, Alex James | Geschäftsführer | Tintagel Gardens SE22 8HS London 1 United Kingdom | British | 135706810001 | ||||||
| SCANNELL, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | c/o C/O Serviced Office Group Long Acre WC2E 9LY London 22 England | England | British | 154659960001 | |||||
| TASCHLER, Jeffery | Geschäftsführer | 18 Leonard St NY 10013 New York Apartment 2c Usa | United States | 135708370001 | ||||||
| WAKELIN, James David | Geschäftsführer | 38 Almeric Road Battersea SW11 1HL London | British | 92221010001 | ||||||
| WASHINGTON, Robert Francis | Geschäftsführer | 133 Stormont Road SW11 5EJ London | Australian | 120776550001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KBC BECKENHAM LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consort Property Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat KBC BECKENHAM LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 31. Dez. 2020 Geliefert am 18. Jan. 2021 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 20. Okt. 2020 Geliefert am 27. Okt. 2020 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Nov. 2012 Geliefert am 29. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben County house, 221 to 241 beckenham road, beckenham, kent t/no SGL19222. By way of fixed charge all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land, the proceeds of sale of the property, the benefit of any rental deposit all rents and other sums due under any lease, all plant and machinery and the benefit of all contracts, licences and warranties and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Nov. 2012 Geliefert am 29. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. County house 221 to 241 beckenham road, beckenham, kent t/no SGL19222 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Nov. 2012 Geliefert am 28. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Kbc kingston limited, f/h 12-50 kingsgate road, kingston t/no SY279853, SY327216, SY254907, SGL124369 and SGL58811, kbc hayes limited, f/h 23 clayton road, hayes t/no AGL2697 and kbc harrow limited, f/h 2 gayton road, harrow t/no NGL571767 together with all rents receivable, all the goodwill, all fixtures and fittings, all plant and machinery see image for full details. For further details of properties charged please see form MG01. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Okt. 2007 Geliefert am 12. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 221-241 beckenham road beckenham t/n SGL19222. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Sept. 2007 Geliefert am 03. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0