MALTHURST PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MALTHURST PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06360537 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MALTHURST PROPERTIES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MALTHURST PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Hertfordshire England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MALTHURST PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MALTHURST PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Sept. 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Aug. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Change of details for Lupo Limited as a person with significant control on 16. Juli 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Ernennung von Thomas Mckenzie Biggart als Direktor am 11. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Pinsent Masons Secretarial Limited als Sekretär am 07. März 2019 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Hathaway als Sekretär am 07. März 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Graham Paul Timbers als Geschäftsführer am 12. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Paul Lane als Direktor am 19. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr William Bahlsen Bannister als Direktor am 19. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Vincent House, 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH zum Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU am 20. Dez. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven John Back als Geschäftsführer am 15. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Graham Paul Timbers als Direktor am 12. Okt. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Karen Juanita Dickens als Geschäftsführer am 22. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 01. Okt. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2017 bis 30. Sept. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MALTHURST PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England |
| 76579530001 | ||||||||||
| BANNISTER, William Bahlsen | Geschäftsführer | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | United Kingdom | British | 252731900001 | |||||||||
| BIGGART, Thomas Mckenzie | Geschäftsführer | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | Scotland | British | 215843640001 | |||||||||
| LANE, Simon Paul | Geschäftsführer | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 252862090001 | |||||||||
| HATHAWAY, David | Sekretär | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | British | 117227730001 | ||||||||||
| IQBAL, Damian Shameem | Sekretär | Vincent House, 4 Grove Lane Epping CM16 4LH Essex | British | 126363060001 | ||||||||||
| D & D SECRETARIAL LTD | Sekretär | Linden House Court Lodge Farm, Warren Road BR6 6ER Chelsfield Kent | 114884700001 | |||||||||||
| BACK, Steven John | Geschäftsführer | Vincent House, 4 Grove Lane Epping CM16 4LH Essex | United Kingdom | British | 205661380001 | |||||||||
| DICKENS, Karen Juanita, Dr | Geschäftsführer | Vincent House, 4 Grove Lane Epping CM16 4LH Essex | United Kingdom | British | 124061360001 | |||||||||
| DWYER, Daniel James | Geschäftsführer | Clovers End Patcham BN1 8PJ Brighton 2 East Sussex | United Kingdom | British | 86094440001 | |||||||||
| LYNN, John Charles | Geschäftsführer | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex | United Kingdom | British | 29838790004 | |||||||||
| PEACOCK, Graham Frederick | Geschäftsführer | Vincent House, 4 Grove Lane Epping CM16 4LH Essex | United Kingdom | British | 5133310002 | |||||||||
| SCOTT, Richard Antony Cargill | Geschäftsführer | Vincent House, 4 Grove Lane Epping CM16 4LH Essex | England | British | 107002130001 | |||||||||
| TIMBERS, Graham Paul | Geschäftsführer | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 127888240001 | |||||||||
| TOBBELL, Susan Margaret | Geschäftsführer | Vincent House, 4 Grove Lane Epping CM16 4LH Essex | United Kingdom | British | 17957620003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MALTHURST PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupo Limited | 06. Apr. 2016 | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St Albans Gladstone Place Hertfordshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MALTHURST PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental legal charge | Erstellt am 03. Dez. 2010 Geliefert am 14. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben South norwood service station corner south norwood hill and holmesdale road london t/no P33581, station road garage station road stow-on-the-wold cheltenham t/no GR260783; all buildings, fixtures, fixed plant and machinery, all easements, rights, agreements, all rents, proceeds of sale. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 24. Sept. 2009 Geliefert am 01. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under or in connection with any finance document | |
Kurze Angaben All the company's present and future right title and interest in and to the acquired property and the charged assets subject to the charges see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rents | Erstellt am 28. Mai 2009 Geliefert am 18. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Lease between malthurst fuels limited and bp oil UK limited dated 1 and 6 april both months 2009 and registered in the books of council and session on 15 april 2009. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 21. Mai 2009 Geliefert am 10. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due | |
Kurze Angaben All the whole the subjects lying on the north side craiglinn park road known as the petrol filling station at black o' hill roundabout cumbernauld glasgow t/no:DMB56956. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 16/11/07 and | Erstellt am 24. Okt. 2007 Geliefert am 06. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben South west of queen's drive kilmarnock t/no AYR16084. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 23/11/07 and | Erstellt am 24. Okt. 2007 Geliefert am 06. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Millfield service station main street polmont falkirk t/no STG46730. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 23/11/07 and | Erstellt am 24. Okt. 2007 Geliefert am 06. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Crossroads filling station 90 dean road bo'ness t/no WLN39354. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 19/11/07 and | Erstellt am 24. Okt. 2007 Geliefert am 06. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben North side of hamilton road carmyle t/no LAN42692. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 16/11/07 and | Erstellt am 24. Okt. 2007 Geliefert am 06. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Newbridge service station cliftonhall road newbridge t/no MID82379. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 14/11/2007 and | Erstellt am 24. Okt. 2007 Geliefert am 04. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Mountfleurie service station windygates road leven t/no FFE75324. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 15 november 2007 and | Erstellt am 24. Okt. 2007 Geliefert am 05. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 565 north anderson drive aberdeen t/n ABN45487. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 24. Okt. 2007 Geliefert am 09. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share mortgage | Erstellt am 24. Okt. 2007 Geliefert am 09. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all present and future shares and dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0