SPRING COPPICE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SPRING COPPICE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06363463 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SPRING COPPICE LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich SPRING COPPICE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Fulford House Newbold Terrace CV32 4EA Leamington Spa Warwickshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SPRING COPPICE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PIMLICO HOMES (SPRING COPPICE DRIVE) LIMITED | 06. Sept. 2007 | 06. Sept. 2007 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPRING COPPICE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SPRING COPPICE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
legacy | 5 Seiten | MG01 | ||
legacy | 5 Seiten | MG01 | ||
Beendigung der Bestellung von Clive Hamilton als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 5 Seiten | AA | ||
legacy | 6 Seiten | MG01 | ||
legacy | 5 Seiten | MG01 | ||
Beendigung der Bestellung von Lynda Lewis als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 5 Seiten | AA | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed pimlico homes (spring coppice drive) LIMITED\certificate issued on 16/09/08 | 2 Seiten | CERTNM | ||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||
legacy | 7 Seiten | 395 | ||
legacy | 11 Seiten | 395 | ||
Gründung | 13 Seiten | NEWINC | ||
Wer sind die Geschäftsführer von SPRING COPPICE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, Brian John Duncan | Sekretär | Fairfield Church Lane Lighthorne CV35 0AR Warwick Warwickshire | British | 51085750002 | ||||||
| LEWIS, Brian John Duncan | Geschäftsführer | Fairfield Church Lane Lighthorne CV35 0AR Warwick Warwickshire | England | British | 51085750002 | |||||
| DOWNING, Martin Richard Frederick | Geschäftsführer | 6 Stamford Croft B91 3FS Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 37584690003 | |||||
| HAMILTON, Clive Stuart | Geschäftsführer | Terra Cotta Park Lane CV37 0LS Snitterfield Stratford Upon Avon | England | British | 96748120001 | |||||
| LEWIS, Lynda Evelyn | Geschäftsführer | Church Lane Lighthorne CV35 0AR Warwick Fairfield Warwickshire | England | British | 137047800001 |
Hat SPRING COPPICE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 21. Okt. 2010 Geliefert am 22. Okt. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due | |
Kurze Angaben 3 nesfield grove, hampton in arden. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Okt. 2010 Geliefert am 23. Okt. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Mai 2010 Geliefert am 05. Juni 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 23 althorpe drive dorridge see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second legal charge | Erstellt am 21. Mai 2010 Geliefert am 05. Juni 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All and any sums owing to the mortgagee | |
Kurze Angaben F/H 23 althorpe drive dorridge solihull t/no WM609465. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Okt. 2007 Geliefert am 01. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H 1 spring coppice drive dorridge solihull t/no WM403475; all rental income fixtures fittings; the proceeds of any insurance affecting the property or assets together with a floating charge over all moveable plant machinery equipment and the undertaking and assets of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Okt. 2007 Geliefert am 01. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 1 spring coppice drive dorridge solihull west midlands t/n WM403475. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Okt. 2007 Geliefert am 01. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0