REDEHAM HOMES (CROWBOROUGH) LTD

REDEHAM HOMES (CROWBOROUGH) LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameREDEHAM HOMES (CROWBOROUGH) LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06392879
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von REDEHAM HOMES (CROWBOROUGH) LTD?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich REDEHAM HOMES (CROWBOROUGH) LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von REDEHAM HOMES (CROWBOROUGH) LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TILMORE DEVELOPMENTS (CROWBOROUGH) LIMITED08. Okt. 200708. Okt. 2007

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REDEHAM HOMES (CROWBOROUGH) LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für REDEHAM HOMES (CROWBOROUGH) LTD?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für REDEHAM HOMES (CROWBOROUGH) LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    17 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Dez. 2014

    13 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Redeham Hall 137 Redehall Road Smallfield Horley Surrey RH6 9RJ* am 04. Jan. 2014

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 21. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 1,992,437
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2012

    12 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt

    1 SeitenAD04

    Ernennung von Mr Robert Joseph Kell als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Bailey als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Tracey Bailey als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2011

    10 SeitenAA

    Geänderte vollständige Konten erstellt bis 30. Apr. 2010

    10 SeitenAAMD

    Geänderte vollständige Konten erstellt bis 30. Apr. 2009

    10 SeitenAAMD

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2010

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Redeham Hall 137 Redehall Road Burston Surrey RH6 9RJ* am 08. Okt. 2010

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von REDEHAM HOMES (CROWBOROUGH) LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KELL, Robert Joseph
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Town Wall House
    Essex
    Geschäftsführer
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Town Wall House
    Essex
    EnglandBritsih110424700002
    BAILEY, Tracey Denise
    Rookwood Park
    RH12 1UB Horsham
    34
    West Sussex
    Sekretär
    Rookwood Park
    RH12 1UB Horsham
    34
    West Sussex
    British139946090001
    HICKEY, Michael Anthony
    Foxwold
    Pipers Lane
    TN16 1NE Brasted Chart
    Kent
    Sekretär
    Foxwold
    Pipers Lane
    TN16 1NE Brasted Chart
    Kent
    Irish20201330003
    MANGAN, Gerrard Michael
    Wathen Road
    RH4 1JY Dorking
    24
    Surrey
    Sekretär
    Wathen Road
    RH4 1JY Dorking
    24
    Surrey
    British135267030001
    BAILEY, Mark Patrick Miles
    34 Rookwood Road
    Horsham
    RH12 1UB West Sussex
    Geschäftsführer
    34 Rookwood Road
    Horsham
    RH12 1UB West Sussex
    United KingdomBritish127356820001
    HEFFER, Bruce Eric
    6 Ellerslie Close
    Hill Head
    PO14 3LH Fareham
    Hampshire
    Geschäftsführer
    6 Ellerslie Close
    Hill Head
    PO14 3LH Fareham
    Hampshire
    United KingdomBritish122254180001
    HICKEY, James Gerard
    Marl Court Pit Lane
    Marl Pit Hill
    TN8 6BD Edenbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    Marl Court Pit Lane
    Marl Pit Hill
    TN8 6BD Edenbridge
    Kent
    EnglandIrish59920540003
    HICKEY, Michael Anthony
    Foxwold
    Pipers Lane
    TN16 1NE Brasted Chart
    Kent
    Geschäftsführer
    Foxwold
    Pipers Lane
    TN16 1NE Brasted Chart
    Kent
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)Irish20201330003

    Hat REDEHAM HOMES (CROWBOROUGH) LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 16. Feb. 2010
    Geliefert am 19. Feb. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 16. Feb. 2010
    Geliefert am 19. Feb. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Feb. 2010
    Geliefert am 19. Feb. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold land known as coombe edge, luxford lane, crowborough t/n ESX312021, the part of the freehold land known as oak view, luxford lane crowborough t/n ESX312266. The freehold land known as land adjoining the lilacs luxford lane crowborough t/n ES312410 the freehold land known as land at the back of four chimneys luxford lane crowborough t/n ESX40980 the freehold land known as tavistock luxford lane crowborough t/n ESX40980 and the freehold land known as 1 havelock villas luxford lane crowborough t/n ESX317387 any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Feb. 2010
    Geliefert am 19. Feb. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold land known as coombe edge, luxford lane, crowborough t/n ESX312021, the part of the freehold land known as oak view, luxford lane crowborough t/n ESX312266. The freehold land known as land adjoining the lilacs luxford lane crowborough t/n ES312410 the freehold land known as land at the back of four chimneys luxford lane crowborough t/n ESX40980 the freehold land known as tavistock luxford lane crowborough t/n ESX40980 and the freehold land known as 1 havelock villas luxford lane crowborough t/n ESX317387 any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Jan. 2008
    Geliefert am 04. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H garden of four chimneys luxford lane crowborough east sussex t/n ESX215268. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Jan. 2008
    Geliefert am 04. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the lilacs luxford lane crowborough east sussex t/n ESX57064. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 06. Dez. 2007
    Geliefert am 11. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Dez. 2007
    Geliefert am 11. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H coombe edge, luxford lane, crowborough, east sussex t/no ESX23726. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat REDEHAM HOMES (CROWBOROUGH) LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Dez. 2013Beginn der Liquidation
    09. Dez. 2015Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Lee De'Ath
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Praktiker
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Richard Howard Toone
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London
    Praktiker
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0