VALAD REAL ESTATE (NO.1) LIMITED

VALAD REAL ESTATE (NO.1) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVALAD REAL ESTATE (NO.1) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06447313
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VALAD REAL ESTATE (NO.1) LIMITED?

    • Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich VALAD REAL ESTATE (NO.1) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BDO LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VALAD REAL ESTATE (NO.1) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für VALAD REAL ESTATE (NO.1) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für VALAD REAL ESTATE (NO.1) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 31. Juli 2014

    7 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    7 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Sept. 2013

    10 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ* am 20. Sept. 2012

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Änderung der Details des Direktors für Mr Martyn James Mccarthy am 30. Apr. 2012

    2 SeitenCH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Dez. 2011

    Kapitalaufstellung am 09. Dez. 2011

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 09. Dez. 2010

    3 SeitenCH04

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010

    15 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 16. Sept. 2010

    3 SeitenCH04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009

    15 SeitenAA

    Ernennung von Valsec Director Limited als Direktor

    3 SeitenAP02

    Beendigung der Bestellung von Peter Hurley als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Didier Tandy als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Martyn James Mccarthy am 07. Dez. 2009

    3 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Peter Edmund Hurley am 06. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 06. Dez. 2009

    2 SeitenCH04

    Änderung der Details des Direktors für Peter Edmund Hurley am 07. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Martyn James Mccarthy am 07. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von VALAD REAL ESTATE (NO.1) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place
    Sekretär
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC219311
    133355520001
    MCCARTHY, Martyn James
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United KingdomAustralian126149680008
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House 20
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House 20
    North Yorkshire
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer5307786
    102622300002
    BLAIN, Andrew John
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Sekretär
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    British40585290002
    BLAIN, Andrew John
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Geschäftsführer
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    ScotlandBritish40585290002
    HURLEY, Peter Edmund
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    AustraliaAustralian121515110004
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Geschäftsführer
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    SWAN, Thomas William
    Flat 0/1
    84 Beith Street
    G11 6DQ Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Flat 0/1
    84 Beith Street
    G11 6DQ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish124786290001
    TANDY, Didier Michel
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish69909950001

    Hat VALAD REAL ESTATE (NO.1) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Jersey law security interest agreement
    Erstellt am 11. Feb. 2008
    Geliefert am 21. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right, title and interest in and to the security assets, assigns the units being 3,273,950 fully paid units in the trust and the related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Jersey law security interest agreement
    Erstellt am 11. Feb. 2008
    Geliefert am 21. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right, title and interest in and to the security assets, assigns the units being 1,126,513 fully paid units in the trust and the related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Agreement
    Erstellt am 28. Jan. 2008
    Geliefert am 02. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the right title and interest in and to the security assets meaning the units and the related rights. Units means 2,082,000 fully paid units in the trust. Related rights means all rights derived from or connected to the units. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. Jan. 2008
    Geliefert am 07. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other member of the group to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (Security Agent)
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Jersey law security interest agreement
    Erstellt am 24. Jan. 2008
    Geliefert am 02. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The security assets being the units being 2,585,500 fully paid units and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Jersey law security interest agreement
    Erstellt am 24. Jan. 2008
    Geliefert am 02. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The security assets being the units being 12,965,000 fully paid units and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Jersey law security interest agreement
    Erstellt am 24. Jan. 2008
    Geliefert am 02. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The security assets being the units being 1,284,085 fully paid units and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)

    Hat VALAD REAL ESTATE (NO.1) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. Sept. 2012Beginn der Liquidation
    15. Nov. 2014Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sarah Megan Rayment
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0