GABBRO PRECISION HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GABBRO PRECISION HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06451211 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GABBRO PRECISION HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich GABBRO PRECISION HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Frp Advisory Llp 110 Cannon Street EC4N 6EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GABBRO PRECISION HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GABBRO PRECISION LIMITED | 07. Juni 2011 | 07. Juni 2011 |
| MATERIAL ADVANTAGE GROUP LIMITED | 09. Feb. 2009 | 09. Feb. 2009 |
| ESS STEELS GROUP HOLDINGS LIMITED | 12. Dez. 2007 | 12. Dez. 2007 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GABBRO PRECISION HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GABBRO PRECISION HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 17 Seiten | LIQ14 | ||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 29 Seiten | AM22 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 23 Seiten | AM10 | ||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 5 Seiten | AM07 | ||
Vorschlag des Verwalters | 65 Seiten | AM03 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Baird Capital Bcpe Finsbury Circus London Uk EC2M 7EB England zum C/O Frp Advisory Llp 110 Cannon Street London EC4N 6EU am 18. Apr. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Deane Vincent Wakeling als Geschäftsführer am 17. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 15 Finsbury Circus London EC2M 7EB England zum Baird Capital Bcpe Finsbury Circus London Uk EC2M 7EB am 13. Aug. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Distington House 26 Atlas Way Sheffield South Yorkshire S4 7QQ England zum 15 Finsbury Circus London EC2M 7EB am 13. Aug. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Douglas Young als Sekretär am 06. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||
Erfüllung der Belastung 064512110013 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 064512110014 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 064512110010 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 064512110012 teilweise | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 064512110011 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Beendigung der Bestellung von Philip David Jackson als Sekretär am 09. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Mr Douglas Young als Sekretär am 09. Apr. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2017 | 42 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Dez. 2017 mit Aktualisierungen | 10 Seiten | CS01 | ||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 06. Mai 2016
| 6 Seiten | SH01 | ||
Ernennung von Mr Philip David Jackson als Sekretär am 01. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von GABBRO PRECISION HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRASS, David John | Geschäftsführer | 43 Birkett Way HP8 4BJ Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | 146153930001 | |||||
| HALL, Dennis John | Geschäftsführer | Home Close 2 Duck End NN29 7SH Wollaston Northamptonshire | United Kingdom | British | 56413380003 | |||||
| BARKER, Phillip | Sekretär | 26 Atlas Way S4 7QQ Sheffield Distington House South Yorkshire England | 157605540001 | |||||||
| HORNE, Steven | Sekretär | Gothic Lodge Compstall Road Romiley SK6 4JG Stockport | British | 53716740003 | ||||||
| JACKSON, Philip David | Sekretär | 26 Atlas Way S4 7QQ Sheffield Distington House South Yorkshire England | 238645190001 | |||||||
| KEIGHLEY, Richard Nicholas | Sekretär | Main Street Saxby-All-Saints DN20 0QB Brigg Park View 48 North Lincolnshire | British | 137305900001 | ||||||
| YOUNG, Douglas | Sekretär | 26 Atlas Way S4 7QQ Sheffield Distington House South Yorkshire England | 245092860001 | |||||||
| BARKER, Philip Dennison | Geschäftsführer | 26 Atlas Way S4 7QQ Sheffield Distington House South Yorkshire England | United Kingdom | British | 40070580001 | |||||
| BENFIELD, James Oliver | Geschäftsführer | Mint House, 77 Mansell Street E1 8AF London | United Kingdom | British | 114250330001 | |||||
| FLETCHER, David | Geschäftsführer | Dearne Mill House 19a Cuckstool Road Denby Dale HD8 8RF Huddersfield | England | British | 15603220002 | |||||
| HORNE, Steven | Geschäftsführer | Gothic Lodge Compstall Road Romiley SK6 4JG Stockport | England | British | 53716740003 | |||||
| KEIGHLEY, Richard Nicholas | Geschäftsführer | Main Street Saxby-All-Saints DN20 0QB Brigg Park View 48 North Lincolnshire | England | British | 137305900001 | |||||
| KIRKHAM, Philip David | Geschäftsführer | Lime Spinney Somersall Close Somersall S40 3SG Chesterfield Derbyshire | England | British | 13484340002 | |||||
| MATTHEWS, Simon Paul | Geschäftsführer | Worksop Road Aston S26 2EB Sheffield 73 | England | British | 129974940002 | |||||
| MILNER, Duncan Paul | Geschäftsführer | Woolley Park Woolley WF4 2JS Wakefield Holme Farm West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 127796890002 | |||||
| PARRY, Keith Robert | Geschäftsführer | 58 Ullswater Drive Dronfield Woodhouse S18 8PN Dronfield Derbyshire | British | 126824700001 | ||||||
| ROBERTS, Gareth Lloyd | Geschäftsführer | 26 Atlas Way S4 7QQ Sheffield Distington House South Yorkshire England | England | British | 222590450001 | |||||
| SENIOR, John Kenneth | Geschäftsführer | 10 Manchester Road Broomhill S10 5DF Sheffield | British | 75544930002 | ||||||
| SMITH, Paul Jeremy, Dr | Geschäftsführer | Victoria Works 31 Catley Road Darnall S9 5JF Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 74597100001 | |||||
| WAKELING, Deane Vincent | Geschäftsführer | 31 Catley Road Darnall S9 5JF Sheffield Victoria Works, United Kingdom | England | British | 36941630007 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GABBRO PRECISION HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baird Capital Partners Europe Limited | 06. Apr. 2016 | Finsbury Circus EC2M 7EB London Finsbury Circus House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat GABBRO PRECISION HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 06. Mai 2016 Geliefert am 23. Mai 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Mai 2016 Geliefert am 23. Mai 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Mai 2016 Geliefert am 23. Mai 2016 | Teilweise erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Mai 2016 Geliefert am 20. Mai 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Juni 2015 Geliefert am 15. Juli 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture creating fixed and floating charges over all the assets and undertakings (present and future) of gabbro precision holdings limited. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 06. Feb. 2012 Geliefert am 10. Feb. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest present and future in and to the acquisition agreement and all proceeds and claims arising from the acquisition agreement see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 06. Feb. 2012 Geliefert am 10. Feb. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All shares stock securities or other rights accruing or offered to be offered by way of rights bonus option or otherwise arising from or in respect of such stocks shares and other marketable securities. 1000 shares midland precision limited ordinary shares of £1.00 each see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 23. Aug. 2010 Geliefert am 27. Aug. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Full title guarantee the mortgagor assigns the policy being the policy of assurance held with aegon scottish equitable policy number L0198408443 dated 27TH july 2010 including all monies assured by all bonuses and other benefits see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage over stocks, shares and collective investment schemes | Erstellt am 03. Juni 2009 Geliefert am 11. Juni 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The securities including costs and interest see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of policy by policy holder | Erstellt am 10. Juli 2008 Geliefert am 16. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The company assigns to the bank the £750,000.00 terminal illness with life cover key person assurance policy over the life of duncan paul milner dated 1 july 2008 with zurich assurance limited, policy number 1 511-2TA-dys see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of assurance policy by policyholder | Erstellt am 20. Juni 2008 Geliefert am 04. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assigns to the bank the £500,000 terminal illness with life cover key person assurance policy over the life of steven horne dated 17 march 2008 with legal & general assurance society, policy number 26762858, including all monies assured by and all bonuses and other benefits of whatever nature under such policy see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 18. Dez. 2007 Geliefert am 03. Jan. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The acquisition agreement being the sale and purchase agreement dated on or around the date hereof and made between (1) the company and (2) the sellers. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage over shares | Erstellt am 18. Dez. 2007 Geliefert am 03. Jan. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 255,500 ordinary shares of £1.00 each in ess steel holdings limited together with all dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Dez. 2007 Geliefert am 03. Jan. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat GABBRO PRECISION HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0