AGRIFOOD CHARITIES PARTNERSHIP

AGRIFOOD CHARITIES PARTNERSHIP

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAGRIFOOD CHARITIES PARTNERSHIP
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital, Befreiung von der Verwendung von 'Limited'
    Unternehmensnummer 06510709
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AGRIFOOD CHARITIES PARTNERSHIP?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich AGRIFOOD CHARITIES PARTNERSHIP?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Morley Business Centre Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Norfolk
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AGRIFOOD CHARITIES PARTNERSHIP?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2025
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2024

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für AGRIFOOD CHARITIES PARTNERSHIP?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis31. Jan. 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung14. Feb. 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis31. Jan. 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für AGRIFOOD CHARITIES PARTNERSHIP?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2025 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Graham John Jellis als Geschäftsführer am 31. Dez. 2024

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2024

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2023

    3 SeitenAA

    Ernennung von Mr Stuart William John Reid als Direktor am 01. Nov. 2023

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2022

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Philip Edward Richardson als Geschäftsführer am 02. Nov. 2022

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Michaela Elizabeth Canham als Sekretär am 02. Nov. 2022

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Stephens als Sekretär am 02. Nov. 2022

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Prof Robert John Bansback als Direktor am 02. Nov. 2022

    2 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Bullock Building University Way Cranfield Bedfordshire MK43 0GH zum Morley Business Centre Deopham Road Morley St. Botolph Wymondham Norfolk NR18 9DF am 25. Nov. 2022

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Ian Charles Munnery als Direktor am 02. Nov. 2022

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2021

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Carl Anthony Edwards als Geschäftsführer am 02. Juni 2021

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2020

    3 SeitenAA

    Ernennung von Reverend Geoffrey John Dodgson als Direktor am 17. Nov. 2020

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Carl Anthony Edwards als Direktor am 17. Nov. 2020

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr James Henry Orson als Direktor am 17. Nov. 2020

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Philip Le Grice als Geschäftsführer am 17. Jan. 2020

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2019

    2 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von AGRIFOOD CHARITIES PARTNERSHIP?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CANHAM, Michaela Elizabeth
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    Sekretär
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    302640920001
    BANSBACK, Robert John, Prof
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    Geschäftsführer
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    EnglandBritishRetired24010530001
    BENNETT, Gordon
    University Way
    Cranfield
    MK43 0GH Bedford
    The Bullock Building
    England
    Geschäftsführer
    University Way
    Cranfield
    MK43 0GH Bedford
    The Bullock Building
    England
    EnglandBritishRetired98103310001
    DODGSON, Geoffrey John, Reverend
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    Geschäftsführer
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    EnglandBritishClerk In Holy Orders153552500001
    MUNNERY, Ian Charles
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    Geschäftsführer
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    EnglandBritishGeneral Manager302640510001
    ORSON, James Henry
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    Geschäftsführer
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    EnglandBritishRetired Agronomist97667670001
    PAYNE, Alex Irena
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    Geschäftsführer
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    EnglandBritishDirector Of Quality264698830001
    REID, Stuart William John
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    Geschäftsführer
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    EnglandBritishPrincipal190315640001
    STEVENS, James Richard
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    Geschäftsführer
    Deopham Road
    Morley St. Botolph
    NR18 9DF Wymondham
    Morley Business Centre
    Norfolk
    England
    EnglandBritishLecturer188581520001
    NAYLOR, David John
    31 Rossendale
    CM1 2UA Chelmsford
    Essex
    Sekretär
    31 Rossendale
    CM1 2UA Chelmsford
    Essex
    British5751830001
    STEPHENS, Elizabeth
    Townsend Mill
    Rectory Road
    MK45 5AT Steppingley
    Bedfordshire
    Sekretär
    Townsend Mill
    Rectory Road
    MK45 5AT Steppingley
    Bedfordshire
    BritishAccountant20959150001
    BISCOE, Paul Victor, Dr
    Tamworth Cottage
    Silbury Court
    MK45 4RU Silsoe
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Tamworth Cottage
    Silbury Court
    MK45 4RU Silsoe
    Bedfordshire
    BritishRetired127948430001
    BURGESS, Anthony Frederick
    University Way
    MK43 0GH Cranfield
    The Bullock Building
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    University Way
    MK43 0GH Cranfield
    The Bullock Building
    Bedfordshire
    EnglandBritishRetired146295840001
    BURGESS, Stuart John, Dr
    83-101 Euston Street
    NW1 2EZ London
    Mic
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    83-101 Euston Street
    NW1 2EZ London
    Mic
    United Kingdom
    EnglandBritishChair Commission Rural Communities29605830002
    CHAMBERLAIN CUTHBERTSON, Anne
    12 Manor Farm
    Apethorpe
    PE8 5DP Peterborough
    Lamlash
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    12 Manor Farm
    Apethorpe
    PE8 5DP Peterborough
    Lamlash
    Northamptonshire
    United KingdomBritishBusiness Consultancy139169230001
    COURTNEY, Jeremy David
    East Hoathly
    BN8 6QX Lewes
    Crouchs Farm
    East Sussex
    England
    Geschäftsführer
    East Hoathly
    BN8 6QX Lewes
    Crouchs Farm
    East Sussex
    England
    EnglandBritishFarmer51265690001
    COURTNEY, Jeremy David
    Crouch's Farm
    East Hoathly
    BN8 6QX Lewes
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Crouch's Farm
    East Hoathly
    BN8 6QX Lewes
    East Sussex
    EnglandBritishFarmer51265690001
    DEVISMES, Louisa May Jacqueline
    Ditchling Road
    Plumpton
    BN7 3AE Lewes
    Plumpton College
    East Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ditchling Road
    Plumpton
    BN7 3AE Lewes
    Plumpton College
    East Sussex
    United Kingdom
    UkBritishEducational Consultant183753400001
    EDWARDS, Carl Anthony
    University Way
    MK43 0GH Cranfield
    The Bullock Building
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    University Way
    MK43 0GH Cranfield
    The Bullock Building
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector Of Public Education276811830001
    GATWARD, Gordon John, Rev Dr
    University Way
    MK43 0GH Cranfield
    The Bullock Building
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    University Way
    MK43 0GH Cranfield
    The Bullock Building
    Bedfordshire
    EnglandBritishRetired77156870002
    JELLIS, Graham John, Professor
    Springhill Road
    CB11 4AH Saffron Walden
    18 Springhill Road
    Essex
    England
    Geschäftsführer
    Springhill Road
    CB11 4AH Saffron Walden
    18 Springhill Road
    Essex
    England
    United KingdomBritishAgibusiness Consultant58639690001
    LAWRENCE, David Charles
    Easton College
    Easton
    NR9 5DX Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Easton College
    Easton
    NR9 5DX Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishCollege Principal40119970001
    LE GRICE, Philip, Dr
    University Way
    MK43 0GH Cranfield
    The Bullock Building
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    University Way
    MK43 0GH Cranfield
    The Bullock Building
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector240203930001
    MOODY, Christopher Ronald
    The Green
    Nether Heyford
    NN7 3LE Northampton
    4b The Green
    England
    Geschäftsführer
    The Green
    Nether Heyford
    NN7 3LE Northampton
    4b The Green
    England
    EnglandBritishChief Executive58706750002
    REDMAN, Peter Lawrence
    44 Drove Road
    SG18 8HD Biggleswade
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    44 Drove Road
    SG18 8HD Biggleswade
    Bedfordshire
    United KingdomBritishRetired50856490001
    REYNOLDS, John Kenneth
    Stable Yard
    Caldecott
    LE16 8GH Market Harborough
    1 Stable Yard
    Rutland
    England
    Geschäftsführer
    Stable Yard
    Caldecott
    LE16 8GH Market Harborough
    1 Stable Yard
    Rutland
    England
    UkBritishNone91264360003
    RICHARDSON, Philip Edward
    Wramplingham Road
    NR18 0SB Wymondham
    16 Vicar Street
    Norfolk
    England
    Geschäftsführer
    Wramplingham Road
    NR18 0SB Wymondham
    16 Vicar Street
    Norfolk
    England
    United KingdomBritishNone13847010003
    SHANNON, David William Francis, Dr
    Old Court
    Ashtead
    KT21 2TS Kingston
    4
    Surrey
    Geschäftsführer
    Old Court
    Ashtead
    KT21 2TS Kingston
    4
    Surrey
    EnglandBritishConsultant128842570001
    TREWHELLA, Roger
    Moorlake
    EX17 5EL Crediton
    Higher Moorlake Cottage
    Devon
    Uk
    Geschäftsführer
    Moorlake
    EX17 5EL Crediton
    Higher Moorlake Cottage
    Devon
    Uk
    EnglandBritishDirector, Adela Booth Associates56231100003
    WIBBERLEY, Edward John, Professor Or Dr
    Orchard Close
    TQ14 0HF Shaldon
    Springvale
    Devon
    Geschäftsführer
    Orchard Close
    TQ14 0HF Shaldon
    Springvale
    Devon
    EnglandBritishProfessor & Agricultural/Resource Mgt Consultant53311820003
    WILSON, William Eric
    90 Lillington Road
    CV32 6LE Leamington Spa
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    90 Lillington Road
    CV32 6LE Leamington Spa
    Warwickshire
    BritainBritishRetired98227840001
    WOOLLEY, Helen Louise
    University Way
    MK43 0GH Cranfield
    The Bullock Building
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    University Way
    MK43 0GH Cranfield
    The Bullock Building
    Bedfordshire
    EnglandBritishCeo51277910001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für AGRIFOOD CHARITIES PARTNERSHIP?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    20. Feb. 2017Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0