ENARA FINANCE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ENARA FINANCE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06545556 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENARA FINANCE LIMITED?
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich ENARA FINANCE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Cardinal House Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENARA FINANCE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THAMES VALLEY ACQUISITION LIMITED | 26. März 2008 | 26. März 2008 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENARA FINANCE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENARA FINANCE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. März 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Goodban am 20. März 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Thorburn-Muirhead am 20. März 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2021 | 18 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Ms Lynette Gillian Krige am 01. Sept. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Ernennung von Ms Lynette Gillian Krige als Direktor am 17. Mai 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. März 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Thorburn am 01. März 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Regus Central Boulevard Shirley Solihull B90 8AG England zum Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ am 19. März 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Vellacott als Geschäftsführer am 01. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Ford David Porter als Geschäftsführer am 01. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr James Thorburn als Direktor am 01. März 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Julianne Baker als Geschäftsführer am 01. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Nick Goodban als Direktor am 01. März 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2020 | 19 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1310 Solihull Parkway Birmingham Business Park Solihull Birmingham B37 7YB zum Regus Central Boulevard Shirley Solihull B90 8AG am 17. Juni 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019 | 16 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 18 Seiten | AA | ||
Notification of Enara Group Limited as a person with significant control on 18. Okt. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ENARA FINANCE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOODBAN, Nicholas James | Geschäftsführer | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | England | British | 274517200003 | |||||||||
| KRIGE, Lynette Gillian | Geschäftsführer | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | England | British | 283338100003 | |||||||||
| THORBURN-MUIRHEAD, James | Geschäftsführer | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | England | British | 135453260002 | |||||||||
| HASSAN, Aatif Naveed | Sekretär | 32 Spencer Road W4 3SP London | British | 123439170001 | ||||||||||
| JACKSON, David | Sekretär | 9-11 Church Street West GU21 6DJ Woking First Floor Church Gate Surrey United Kingdom | British | 280628560001 | ||||||||||
| MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England |
| 173209730001 | ||||||||||
| BAKER, Julianne | Geschäftsführer | Central Boulevard Shirley B90 8AG Solihull Regus England | United Kingdom | British | 192429900001 | |||||||||
| BOOTY, Stephen Martin | Geschäftsführer | 9-11 Church Street West GU21 6DJ Woking First Floor Church Gate Surrey United Kingdom | England | British | 147928010001 | |||||||||
| DOBELL, Colin Andrew | Geschäftsführer | Hawksworth Road Central Park TF2 9TL Telford 1 Shropshire | England | British | 63959230003 | |||||||||
| DUN, Andrew Frederick | Geschäftsführer | Monarch Court The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 | United Kingdom | British | 85855780002 | |||||||||
| FELTON, Wayne Harold | Geschäftsführer | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 173205650001 | |||||||||
| FLANAGAN, Jeffrey Paul | Geschäftsführer | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 50878080003 | |||||||||
| GRAY, Susan Annette | Geschäftsführer | 9-11 Church Street West GU21 6DJ Woking First Floor Church Gate Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 55858850004 | |||||||||
| HARLAND, David Nicholas | Geschäftsführer | Monarch Court The Brooms BS16 7FH Bristol 8 England | England | British | 173208950001 | |||||||||
| HASSAN, Aatif Naveed | Geschäftsführer | Monarch Court The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 | England | British | 123439170001 | |||||||||
| JACKSON, David | Geschäftsführer | 9-11 Church Street West GU21 6DJ Woking First Floor Church Gate Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 280628560001 | |||||||||
| MANNAN, Rohit | Geschäftsführer | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | England | British | 181783660001 | |||||||||
| PORTER, Ford David | Geschäftsführer | Central Boulevard Shirley B90 8AG Solihull Regus England | England | British,American | 103327290005 | |||||||||
| RATTLE, Philip Michael | Geschäftsführer | Monarch Court The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 | United Kingdom | British | 85930200001 | |||||||||
| SINGH, Narinder | Geschäftsführer | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YB Solihull 1310 Birmingham | England | British | 193406470001 | |||||||||
| STAUNTON, Martin | Geschäftsführer | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 192431160001 | |||||||||
| STIRLAND, Patrick Walter | Geschäftsführer | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England | United Kingdom | British | 69756530007 | |||||||||
| VELLACOTT, Jonathan James | Geschäftsführer | Central Boulevard Shirley B90 8AG Solihull Regus England | England | British | 250741990001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENARA FINANCE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enara Group Limited | 18. Okt. 2018 | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YB Birmingham 1310 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Cheif Financial Officer Julianne Baker | 01. März 2017 | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YB Solihull 1310 Birmingham | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ENARA FINANCE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over deposit | Erstellt am 01. Dez. 2011 Geliefert am 08. Dez. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All present and future right title benefit and interest in and to the blocked account and the deposit see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Erstellt am 21. Okt. 2009 Geliefert am 06. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any one or more of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The keyman policy being the keyman insurance policy together with its beneficial interest see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment by way of security of keyman life policies | Erstellt am 29. Sept. 2009 Geliefert am 13. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The keyman insurance policies issued by aviva life and pensions UK limited to enara finance limited with policy nos 3272147EX and 3272154EX see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Apr. 2009 Geliefert am 15. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge over a deposit | Erstellt am 08. Apr. 2009 Geliefert am 15. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Present and future right title benefit and interest in and to the blocked account and the deposit by way of first fixed charge. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0