ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED

ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06576312
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o KAY JOHNSON GEE CORPORATE RECOVERY LIMITED
    1 City Road East
    M15 4PN Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ONEDIN GENERAL PARTNER LIMITED20. Juni 200820. Juni 2008
    PIMCO 2773 LIMITED25. Apr. 200825. Apr. 2008

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    16 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Sept. 2017

    22 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Sept. 2016

    13 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester Lancashire M3 5EQ zum C/O Kay Johnson Gee Corporate Recovery Limited 1 City Road East Manchester M15 4PN am 15. Juni 2016

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Centrix House Crow Lane East Newton Le Willows Merseyside WA12 9UY zum Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester Lancashire M3 5EQ am 03. Okt. 2015

    3 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 04. Sept. 2015

    LRESEX

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 21. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Malcolm William Jackson als Geschäftsführer am 29. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Isabel Anne Mulroy als Geschäftsführer am 29. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    14 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 16. Mai 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    14 SeitenAA

    Ernennung von Isabel Anne Mulroy als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Trevor Waggett als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    14 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JACKSON, Malcolm William
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    Sekretär
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    British62603060001
    DOWNES, John Alfred
    16 Field Lane
    Appleton
    WA4 5JF Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    16 Field Lane
    Appleton
    WA4 5JF Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish59635480003
    GRAHAM, Neil
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish157234940001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    CRAMOND, David John
    Embleton Drive
    DH2 3JS Chester Le Street
    33
    County Durham
    Geschäftsführer
    Embleton Drive
    DH2 3JS Chester Le Street
    33
    County Durham
    United KingdomBritish135860150001
    JACKSON, Malcolm William
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    Geschäftsführer
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    United KingdomBritish62603060001
    MULROY, Isabel Anne
    Kingsway
    Team Valley
    NE11 0NA Gateshead
    Homes And Communities Agency St Georges House
    Tyne And Wear
    Uk
    Geschäftsführer
    Kingsway
    Team Valley
    NE11 0NA Gateshead
    Homes And Communities Agency St Georges House
    Tyne And Wear
    Uk
    UkBritish170524310001
    PAGE, Malcolm Douglas
    2 Cauldwell Close
    Monkseaton
    NE25 8LP Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    2 Cauldwell Close
    Monkseaton
    NE25 8LP Whitley Bay
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish112804370001
    ROWLEY, Edwin John
    8 Holywell Green
    TS16 9HH Stockton
    Geschäftsführer
    8 Holywell Green
    TS16 9HH Stockton
    British97096850001
    WAGGETT, Trevor John
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    EnglandBritish104786440001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    128143250001

    Hat ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement: agency c loan notes
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 03. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • One Northeast
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2009
    Security agreement: b loan notes
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 03. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • One Northeast
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2009
    Security agreement: agency a loan notes
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 03. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • One Northeast
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2009
    Security agreement psp a loan notes
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 08. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at newburn industrial estate, newburn t/no TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315490. F/h land on the south side of leamington road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315503. (For further details of properties charged please refer to form 395) and all plant, machinery or equipment. All benefits in respect of the insurances see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Langtree Northeast Limited (Psp)
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement psp c loan notes
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 08. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at newburn industrial estate, newburn t/n TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315490. F/h land on the south side of leamingon road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315503 (for details of further properties charged please refer to form 395) and fixed charge all plant machiney, insurances and shares see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Langtree Northeast Limited
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed charge:c loan designated account
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 03. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge the sums standing from time to time to the credit of the c loan designated account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • One Northeast
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)

    Hat ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    04. Sept. 2015Beginn der Liquidation
    15. Feb. 2019Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Peter James Anderson
    Griffin Court 201 Chapel Street
    M3 5EQ Salford
    Lancashire
    Praktiker
    Griffin Court 201 Chapel Street
    M3 5EQ Salford
    Lancashire
    Alan David Fallows
    Griffin Court 201 Chapel Street
    Salford
    M3 5EQ Manchester
    Praktiker
    Griffin Court 201 Chapel Street
    Salford
    M3 5EQ Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0