ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06576312 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o KAY JOHNSON GEE CORPORATE RECOVERY LIMITED 1 City Road East M15 4PN Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ONEDIN GENERAL PARTNER LIMITED | 20. Juni 2008 | 20. Juni 2008 |
| PIMCO 2773 LIMITED | 25. Apr. 2008 | 25. Apr. 2008 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 16 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Sept. 2017 | 22 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Sept. 2016 | 13 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester Lancashire M3 5EQ zum C/O Kay Johnson Gee Corporate Recovery Limited 1 City Road East Manchester M15 4PN am 15. Juni 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Centrix House Crow Lane East Newton Le Willows Merseyside WA12 9UY zum Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester Lancashire M3 5EQ am 03. Okt. 2015 | 3 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 6 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Malcolm William Jackson als Geschäftsführer am 29. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Isabel Anne Mulroy als Geschäftsführer am 29. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Isabel Anne Mulroy als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Trevor Waggett als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON, Malcolm William | Sekretär | 1 Kingsbury Close Appleton WA4 5FF Warrington | British | 62603060001 | ||||||
| DOWNES, John Alfred | Geschäftsführer | 16 Field Lane Appleton WA4 5JF Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 59635480003 | |||||
| GRAHAM, Neil | Geschäftsführer | Goldcrest Way Newburn Riverside NE15 8NY Newcastle Upon Tyne One North East Stella House Tyne & Wear | United Kingdom | British | 157234940001 | |||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
| CRAMOND, David John | Geschäftsführer | Embleton Drive DH2 3JS Chester Le Street 33 County Durham | United Kingdom | British | 135860150001 | |||||
| JACKSON, Malcolm William | Geschäftsführer | 1 Kingsbury Close Appleton WA4 5FF Warrington | United Kingdom | British | 62603060001 | |||||
| MULROY, Isabel Anne | Geschäftsführer | Kingsway Team Valley NE11 0NA Gateshead Homes And Communities Agency St Georges House Tyne And Wear Uk | Uk | British | 170524310001 | |||||
| PAGE, Malcolm Douglas | Geschäftsführer | 2 Cauldwell Close Monkseaton NE25 8LP Whitley Bay Tyne & Wear | United Kingdom | British | 112804370001 | |||||
| ROWLEY, Edwin John | Geschäftsführer | 8 Holywell Green TS16 9HH Stockton | British | 97096850001 | ||||||
| WAGGETT, Trevor John | Geschäftsführer | Goldcrest Way Newburn Riverside NE15 8NY Newcastle Upon Tyne One North East Stella House Tyne & Wear | England | British | 104786440001 | |||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Park Row LS1 5AB Leeds 1 West Yorkshire | 128143250001 |
Hat ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement: agency c loan notes | Erstellt am 31. März 2009 Geliefert am 03. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement: b loan notes | Erstellt am 31. März 2009 Geliefert am 03. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement: agency a loan notes | Erstellt am 31. März 2009 Geliefert am 03. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement psp a loan notes | Erstellt am 31. März 2009 Geliefert am 08. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at newburn industrial estate, newburn t/no TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315490. F/h land on the south side of leamington road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315503. (For further details of properties charged please refer to form 395) and all plant, machinery or equipment. All benefits in respect of the insurances see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement psp c loan notes | Erstellt am 31. März 2009 Geliefert am 08. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at newburn industrial estate, newburn t/n TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315490. F/h land on the south side of leamingon road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315503 (for details of further properties charged please refer to form 395) and fixed charge all plant machiney, insurances and shares see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge:c loan designated account | Erstellt am 31. März 2009 Geliefert am 03. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge the sums standing from time to time to the credit of the c loan designated account see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0