ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED

ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06623768
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Centrix House
    Crow Lane East
    WA12 9UY Newton Le Willows
    Merseyside
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ONEDIN (NOMINEES) LIMITED07. Juli 200807. Juli 2008
    PIMCO 2789 LIMITED18. Juni 200818. Juni 2008

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 21. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Malcolm William Jackson als Geschäftsführer am 19. Dez. 2014

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 21. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Isabel Anne Mulroy als Geschäftsführer am 18. Feb. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Juli 2013

    Kapitalaufstellung am 23. Juli 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Ernennung von Isabel Anne Mulroy als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Trevor Waggett als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011

    5 SeitenAA

    Ernennung von Trevor John Waggett als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Neil Graham als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Cramond als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Malcolm Page als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    5 SeitenAA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed onedin (nominees) LIMITED\certificate issued on 09/07/09
    3 SeitenCERTNM

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    395

    Wer sind die Geschäftsführer von ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JACKSON, Malcolm William
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    Sekretär
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    British62603060001
    DOWNES, John Alfred
    16 Field Lane
    Appleton
    WA4 5JF Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    16 Field Lane
    Appleton
    WA4 5JF Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish59635480003
    GRAHAM, Neil
    Goldcrest Way Newburn
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Goldcrest Way Newburn
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish157234940001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    CRAMOND, David John
    Embleton Drive
    DH2 3JS Chester Le Street
    33
    County Durham
    Geschäftsführer
    Embleton Drive
    DH2 3JS Chester Le Street
    33
    County Durham
    United KingdomBritish135860150001
    JACKSON, Malcolm William
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    Geschäftsführer
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    United KingdomBritish62603060001
    MULROY, Isabel Anne
    Kingsway
    Team Valley
    NE11 0NA Gateshead
    Homes And Communities Agency St Georges House
    Tyne And Wear
    Uk
    Geschäftsführer
    Kingsway
    Team Valley
    NE11 0NA Gateshead
    Homes And Communities Agency St Georges House
    Tyne And Wear
    Uk
    UkBritish170524310001
    PAGE, Malcolm Douglas
    2 Cauldwell Close
    Monkseaton
    NE25 8LP Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    2 Cauldwell Close
    Monkseaton
    NE25 8LP Whitley Bay
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish112804370001
    WAGGETT, Trevor John
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    EnglandBritish104786440001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    128143250001

    Hat ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement: agency c loan notes
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 06. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • One Northeast (The Agency)
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement: b loan notes
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 06. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northeast One (The Agency)
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement: agency a loan notes
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 06. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • One Northeast (The Agency)
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement psp a loan notes
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 08. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at newburn industrial estate, newburn t/no TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315490. F/h land on the south side of leamington road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315503. (For further details of properties charged please refer to form 395) and all plant, machinery or equipment. All benefits in respect of the insurances see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Langtree Northeast Limited (Psp)
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement psp c loan notes
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 08. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at newburn industrial estate, newburn t/n TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315490. F/h land on the south side of leamingon road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315503 (for details of further properties charged please refer to form 395) and fixed charge all plant machiney, insurances and shares see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Langtree Northeast Limited
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Apr. 2009

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0