ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06623768 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Centrix House Crow Lane East WA12 9UY Newton Le Willows Merseyside |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ONEDIN (NOMINEES) LIMITED | 07. Juli 2008 | 07. Juli 2008 |
| PIMCO 2789 LIMITED | 18. Juni 2008 | 18. Juni 2008 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Malcolm William Jackson als Geschäftsführer am 19. Dez. 2014 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Isabel Anne Mulroy als Geschäftsführer am 18. Feb. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Isabel Anne Mulroy als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Trevor Waggett als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Trevor John Waggett als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Neil Graham als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Cramond als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Malcolm Page als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed onedin (nominees) LIMITED\certificate issued on 09/07/09 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 395 | |||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON, Malcolm William | Sekretär | 1 Kingsbury Close Appleton WA4 5FF Warrington | British | 62603060001 | ||||||
| DOWNES, John Alfred | Geschäftsführer | 16 Field Lane Appleton WA4 5JF Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 59635480003 | |||||
| GRAHAM, Neil | Geschäftsführer | Goldcrest Way Newburn Newburn Riverside NE15 8NY Newcastle Upon Tyne One North East Stella House Tyne & Wear | United Kingdom | British | 157234940001 | |||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
| CRAMOND, David John | Geschäftsführer | Embleton Drive DH2 3JS Chester Le Street 33 County Durham | United Kingdom | British | 135860150001 | |||||
| JACKSON, Malcolm William | Geschäftsführer | 1 Kingsbury Close Appleton WA4 5FF Warrington | United Kingdom | British | 62603060001 | |||||
| MULROY, Isabel Anne | Geschäftsführer | Kingsway Team Valley NE11 0NA Gateshead Homes And Communities Agency St Georges House Tyne And Wear Uk | Uk | British | 170524310001 | |||||
| PAGE, Malcolm Douglas | Geschäftsführer | 2 Cauldwell Close Monkseaton NE25 8LP Whitley Bay Tyne & Wear | United Kingdom | British | 112804370001 | |||||
| WAGGETT, Trevor John | Geschäftsführer | Goldcrest Way Newburn Riverside NE15 8NY Newcastle Upon Tyne One North East Stella House Tyne & Wear | England | British | 104786440001 | |||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Park Row LS1 5AB Leeds 1 West Yorkshire | 128143250001 |
Hat ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement: agency c loan notes | Erstellt am 31. März 2009 Geliefert am 06. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement: b loan notes | Erstellt am 31. März 2009 Geliefert am 06. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement: agency a loan notes | Erstellt am 31. März 2009 Geliefert am 06. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement psp a loan notes | Erstellt am 31. März 2009 Geliefert am 08. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at newburn industrial estate, newburn t/no TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315490. F/h land on the south side of leamington road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315503. (For further details of properties charged please refer to form 395) and all plant, machinery or equipment. All benefits in respect of the insurances see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement psp c loan notes | Erstellt am 31. März 2009 Geliefert am 08. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at newburn industrial estate, newburn t/n TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315490. F/h land on the south side of leamingon road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315503 (for details of further properties charged please refer to form 395) and fixed charge all plant machiney, insurances and shares see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0