BRIDGE BP REALISATIONS LIMITED

BRIDGE BP REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRIDGE BP REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06715847
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRIDGE BP REALISATIONS LIMITED?

    • Einzelhandel mit Schuhen in spezialisierten Geschäften (47721) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich BRIDGE BP REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRIDGE BP REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BARRATTS PRICELESS LIMITED24. Feb. 200924. Feb. 2009
    SOLARBROAD LIMITED06. Okt. 200806. Okt. 2008

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRIDGE BP REALISATIONS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Juli 2011
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Apr. 2012
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRIDGE BP REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    16 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Nov. 2015

    17 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Nov. 2014

    20 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Nov. 2013

    18 Seiten4.68

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    5 SeitenF10.2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Nov. 2012

    27 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Juni 2012

    56 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Juni 2012

    56 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    12 Seiten2.16B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    2 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    86 Seiten2.17B

    Beendigung der Bestellung von Ann Mcgookin als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed barratts priceless LIMITED\certificate issued on 23/01/12
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name23. Jan. 2012

    Beschluss zur Änderung der Firma am 13. Jan. 2012

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Beendigung der Bestellung von John Hood als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Bpl House 880 Harrogate Road Apperley Bridge Bradford West Yorkshire BD10 1NW* am 20. Dez. 2011

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Richard Segal als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Richard Lawrence Segal als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Okt. 2011

    Kapitalaufstellung am 10. Okt. 2011

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Richard Bott als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von BRIDGE BP REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LOCKYER, David Edwin
    880 Harrogate Road
    Apperely Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    880 Harrogate Road
    Apperely Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish127135560001
    WEAVING, John Martin
    880 Harrogate Road
    Apperely Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    880 Harrogate Road
    Apperely Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish137729810001
    ZIFF, Michael Anthony
    880 Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    880 Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish9804810001
    TWO YEARS LIMITED
    880 Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    880 Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer6808747
    137729950001
    MCGOOKIN, Ann Elizabeth
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Sekretär
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    British139073520001
    BOND, Terence Edgar
    3 Lapwing Crescent
    SN14 6YF Chippenham
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    3 Lapwing Crescent
    SN14 6YF Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritish90084650001
    BOTT, Richard Phillip
    880 Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    880 Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    UkBritish43649330001
    HOOD, John
    Harrogate Road
    Apperely Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House 880
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Harrogate Road
    Apperely Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House 880
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish71851720001
    SEGAL, Richard Lawrence
    880 Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    880 Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish138744060001
    STANTON, Howard Terence
    96 Manor Road
    IG7 5PQ Chigwell
    Essex
    Geschäftsführer
    96 Manor Road
    IG7 5PQ Chigwell
    Essex
    United KingdomBritish52013920003
    STARK, Ron Arthur
    880 Harrogate Road
    Aperely Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    880 Harrogate Road
    Aperely Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish167929430001
    TOWNSEND, Paul Michael
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    Geschäftsführer
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    EnglandBritish163717640001
    ZIFF, Edward Max
    12 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    12 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish2002850001

    Hat BRIDGE BP REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of admission
    Erstellt am 27. Apr. 2011
    Geliefert am 30. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing to the bank represented by that sum and credit balances means all of them.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 27. Apr. 2011
    Geliefert am 30. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 19 february 2009 and
    Erstellt am 05. Jan. 2011
    Geliefert am 07. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage
    Erstellt am 14. Sept. 2010
    Geliefert am 28. Sept. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    208A eyre square shopping centre county galway ireland together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage deed to secure own liabilities
    Erstellt am 09. Sept. 2010
    Geliefert am 15. Sept. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H 785 bristol road south northfield birmingham t/n WK186201 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage deed to secure own liabilities
    Erstellt am 09. Sept. 2010
    Geliefert am 15. Sept. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H 297 oxford street and 15 hanover square london t/n NGL830854 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 20. Okt. 2009
    Geliefert am 23. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Composite guarantee and debentures
    Erstellt am 02. Aug. 2009
    Geliefert am 05. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Arnold Securities Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 02. Aug. 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Erstellt am 16. Juli 2009
    Geliefert am 18. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC barratts priceless limited and numbered 300005/184550 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Feb. 2009
    Geliefert am 27. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The scheduled property,all f/h and l/h property,all intellectual property,all the plant and machinery,goodwill and uncalled capital see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Arnold Securities Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Feb. 2009
    Geliefert am 24. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as solarbroad limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 19. Feb. 2009
    Geliefert am 24. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as solarbroad limited and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)

    Hat BRIDGE BP REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Dez. 2011Beginn der Verwaltung
    28. Nov. 2012Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praktiker
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DatumTyp
    28. Nov. 2012Beginn der Liquidation
    15. Mai 2017Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praktiker
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0