ASCRIBE GROUP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ASCRIBE GROUP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 06724472 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ASCRIBE GROUP LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ASCRIBE GROUP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ASCRIBE GROUP LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SCROLL HOLDINGS LIMITED | 15. Okt. 2008 | 15. Okt. 2008 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASCRIBE GROUP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ASCRIBE GROUP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 07. Okt. 2022
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 23. Aug. 2022
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Okt. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA England zum Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Change of details for Emis Group Plc as a person with significant control on 30. Nov. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Rawdon House Green Lane Yeadon Leeds LS19 7BY zum Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA am 02. Dez. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Okt. 2019 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ASCRIBE GROUP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENSON, Christine | Sekretär | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | 239341130001 | |||||||
SOUTHBY, Peter John | Geschäftsführer | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | England | British | Financial Controller | 116859780002 | ||||
STEWART, Paul | Geschäftsführer | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | England | British | Finance Director | 262072580001 | ||||
DICKSON, Christopher John | Sekretär | Upton Grange Wonston SO21 3LR Winchester | British | Doctor | 100748280003 | |||||
FARBRIDGE, Caroline Louise | Sekretär | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | 183344080001 | |||||||
LEE, Jeremy Stephen William | Sekretär | 10 Hodge Fold SK14 6BL Broadbottom Cheshire | British | Director | 98814590001 | |||||
MOTTRAM, Mandy Joanne | Sekretär | Branker Street Westhoughton BL5 3JD Bolton Ascribe House | 170621000001 | |||||||
WAITE, Simon Nicholas | Sekretär | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House | 213730550001 | |||||||
HAMMONDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London 7 | 128059250001 | |||||||
BARBER, Dean Anthony | Geschäftsführer | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House | England | British | Group Financial Controller | 230739040001 | ||||
CRITCHLOW, Anthony Stephen | Geschäftsführer | Grange Farm Grange Road Bromley Cross BL7 9AX Bolton | United Kingdom | British | Director | 101716720002 | ||||
CROSSLEY, Peter Mortimer | Geschäftsführer | Devonshire Square EC2M 4YH London 7 | United Kingdom | British | Solicitor | 83608220004 | ||||
DAVIS, Neville | Geschäftsführer | Manyons Church Lane Barkway SG8 8EJ Royston Hertfordshire | England | British | Co Director | 17829820001 | ||||
DICKSON, Christopher John | Geschäftsführer | Upton Grange Wonston SO21 3LR Winchester | England | British | Doctor | 100748280003 | ||||
EWING, David Harry | Geschäftsführer | Manley Lane Manley WA6 9JE Frodsham Manley Hall Cheshire | England | British | Venture Capitalist | 151432140001 | ||||
FOSTER, Suzanne Marie | Geschäftsführer | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House | England | British | Director | 262072440001 | ||||
LEE, Jeremy Stephen William | Geschäftsführer | 10 Hodge Fold SK14 6BL Broadbottom Cheshire | United Kingdom | British | Director | 98814590001 | ||||
SPENCER, Christopher Michael Kennedy | Geschäftsführer | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British | Chief Executive | 4742550002 | ||||
TAMBLYN, Christina | Geschäftsführer | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British | Financial Director | 191028210001 | ||||
TOWNEND, Nicholas Adam | Geschäftsführer | Branker Street Westhoughton BL5 3JD Bolton Ascribe House | England | British | Finance Director | 154577090001 | ||||
HAMMONDS DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London 7 | 128059260001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ASCRIBE GROUP LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emis Group Plc | 06. Apr. 2016 | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ASCRIBE GROUP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 26. März 2009 Geliefert am 01. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of policy by policy holder to secure own account | Erstellt am 10. März 2009 Geliefert am 12. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assigned the policy, policy being date of policy:20 january 2009, assurance office:legal & general assurance society limited,policy number:013231647-2,amount assured:£500,000,life assured: mr jeremy stephen william lee see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of policy by policy holder to secure own account | Erstellt am 10. März 2009 Geliefert am 12. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assigned the policy, policy being date of policy:15 december 2008, assurance office:legal & general assurance society limited,policy number:013222071-6,amount assured:£1,000,000,life assured: anthony stephen critchlow see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of policy by policy holder to secure own account | Erstellt am 10. März 2009 Geliefert am 12. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assigned the policy, policy being date of policy:15 december 2008, assurance office:legal & general assurance society limited,policy number:013222166-4,amount assured:£500,000,life assured: dr christopher john dickson see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 17. Dez. 2008 Geliefert am 23. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Dez. 2008 Geliefert am 18. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage over stocks and shares by owner to secure own account | Erstellt am 17. Dez. 2008 Geliefert am 18. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The stocks, shares and other marketable securities together with all dividends, 1 share - schroll bidco limited - ordinary, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0