ONE YEAR LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameONE YEAR LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06772345
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ONE YEAR LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich ONE YEAR LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ONE YEAR LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SECOND & THIRD LIMITED12. Dez. 200812. Dez. 2008

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ONE YEAR LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für ONE YEAR LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. Nov. 2012

    51 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 16. Nov. 2012

    51 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Juni 2012

    56 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Juni 2012

    56 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    86 Seiten2.17B

    Beendigung der Bestellung von Ann Elizabeth Mcgookin als Sekretär am 13. Jan. 2012

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Bpl House 880 Harrogate Road Apperley Bridge Bradford West Yorkshire BD10 1NW am 20. Dez. 2011

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Richard Phillip Bott als Geschäftsführer am 12. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2010

    2 SeitenAA

    legacy

    7 SeitenMG01

    legacy

    16 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Jan. 2011

    Kapitalaufstellung am 26. Jan. 2011

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Two Years Limited am 12. Dez. 2010

    2 SeitenCH02

    Änderung der Details des Direktors für Mr Edward Max Ziff am 12. Dez. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Dr Michael Anthony Ziff am 12. Dez. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Martin Weaving am 12. Dez. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Phillip Bott am 12. Dez. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Miss Ann Elizabeth Mcgookin am 12. Dez. 2010

    1 SeitenCH03

    legacy

    6 SeitenMG01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Stylo House Harrogate Road Apperley Bridge Bradford West Yorkshire BD10 0NW am 16. Aug. 2010

    2 SeitenAD01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Apr. 2010 bis 31. Juli 2010

    3 SeitenAA01

    Wer sind die Geschäftsführer von ONE YEAR LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WEAVING, John Martin
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector137729810001
    ZIFF, Edward Max
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector2002850001
    ZIFF, Michael Anthony
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector9804810001
    TWO YEARS LIMITED
    880 Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    880 Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 0NW Bradford
    Bpl House
    West Yorkshire
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer6808747
    137729950001
    MCGOOKIN, Ann Elizabeth
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Sekretär
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    British139073520001
    BOTT, Richard Phillip
    Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 1NW Bradford
    Bpl House 880
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Harrogate Road
    Apperley Bridge
    BD10 1NW Bradford
    Bpl House 880
    West Yorkshire
    UkBritishDirector43649330001
    NAISH, Richard David Charles
    7 High Street
    Clifford
    LS23 6JF Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    7 High Street
    Clifford
    LS23 6JF Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritishSolicitor119308590001
    ROUND, Jonathon Charles
    York Place
    LS1 2DS Leeds
    12
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    York Place
    LS1 2DS Leeds
    12
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritishChartered Secretary133533340001

    Hat ONE YEAR LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of admission
    Erstellt am 27. Apr. 2011
    Geliefert am 30. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing to the bank represented by that sum and credit balances means all of them.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 27. Apr. 2011
    Geliefert am 30. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 19 february 2009 and
    Erstellt am 05. Jan. 2011
    Geliefert am 07. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 20. Okt. 2009
    Geliefert am 23. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Composite guarantee and debentures
    Erstellt am 02. Aug. 2009
    Geliefert am 05. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Arnold Securities Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 02. Aug. 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Feb. 2009
    Geliefert am 27. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The scheduled property,all f/h and l/h property,all intellectual property,all the plant and machinery,all the goodwill and uncalled capital see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Arnold Securities (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Feb. 2009
    Geliefert am 24. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 19. Feb. 2009
    Geliefert am 24. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)

    Hat ONE YEAR LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Dez. 2011Beginn der Verwaltung
    16. Nov. 2012Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praktiker
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0