MDNX CIG LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MDNX CIG LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06801206 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MDNX CIG LIMITED?
- Drahtgebundene Telekommunikation (61100) / Information und Kommunikation
- Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Aktivitäten (63110) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich MDNX CIG LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o INTEROUTE COMMUNICATIONS LIMITED 31st Floor 25 Canada Square E14 5LQ London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MDNX CIG LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COMMUNITY INTERNET GROUP LIMITED | 26. Jan. 2009 | 26. Jan. 2009 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MDNX CIG LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MDNX CIG LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Yasmin Jaffer als Geschäftsführer am 13. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Catherine Birkett am 02. Okt. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom St James House Oldbury Bracknell Berkshire RG12 8th England zum 31st Floor 25 Canada Square Canary Wharf London E14 5LQ geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Allan Shearing als Geschäftsführer am 15. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse St James House Oldbury Bracknell Berkshire RG12 8th verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf St James House Oldbury Bracknell Berkshire RG12 8th geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 068012060007 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Nov. 2015 bis 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom St James House Oldbury Bracknell Berkshire RG12 8th zum C/O Interoute Communications Limited 31st Floor 25 Canada Square London E14 5LQ am 21. Okt. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark James Thompson als Geschäftsführer am 15. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Timothy Mulford als Geschäftsführer am 15. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Catherine Birkett als Direktor am 15. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Wayne Winston Churchill als Geschäftsführer am 15. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von John Shearing als Direktor am 15. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Gareth John Williams als Direktor am 15. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Yasmin Jaffer als Direktor am 15. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2014 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2015 bis 30. Nov. 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MDNX CIG LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRKETT, Catherine | Geschäftsführer | c/o Interoute Communications Limited 25 Canada Square E14 5LQ London 31st Floor England | England | British | 201977420002 | |||||
| WILLIAMS, Gareth John | Geschäftsführer | c/o Interoute Communications Limited 25 Canada Square E14 5LQ London 31st Floor England | United Kingdom | British | 126668950001 | |||||
| BRYAN, Shelby | Geschäftsführer | 4265 San Felipe Suite 1413 Houston Texas 77027 Usa | United States | 74294440001 | ||||||
| CHURCHILL, Wayne Winston | Geschäftsführer | Oldbury RG12 8TH Bracknell St James House Berkshire United Kingdom | England | South African | 155037400001 | |||||
| HARE, Matthew William Edward | Geschäftsführer | Keppel Cottage Cogges Lane, Stanton Harcourt OX8 1AH Witney Oxfordshire | England | British | 48232230003 | |||||
| JAFFER, Yasmin | Geschäftsführer | c/o Interoute Communications Limited 25 Canada Square E14 5LQ London 31st Floor England | Bulgaria | British | 202048620001 | |||||
| KRUEGER, Helmut | Geschäftsführer | Triftstrasse 10 FOREIGN Munich 80538 Germany | German | 124715330001 | ||||||
| MULFORD, Michael Timothy | Geschäftsführer | Oldbury RG12 8TH Bracknell St James House Berkshire United Kingdom | England | British | 20912630005 | |||||
| MULFORD, Michael Timothy | Geschäftsführer | Overdale Lodge Lincombe Lane Boars Hill OX1 5DU Oxford Oxfordshire | England | British | 20912630005 | |||||
| PADFIELD, Philip John | Geschäftsführer | The Eyot House RG4 6TN Sonning Eye Oxfordshire | United Kingdom | British | 67589600002 | |||||
| SHEARING, John Allan | Geschäftsführer | c/o Interoute Communications Limited 25 Canada Square E14 5LQ London 31st Floor England | Belgium | British | 191514220001 | |||||
| THOMPSON, Mark James | Geschäftsführer | Brook Drive Green Park RG2 6UB Reading 200 Berkshire | United Kingdom | British | 136456200001 | |||||
| WILLIAMS, Richard Mark | Geschäftsführer | Brook Drive Green Park RG2 6UB Reading 200 Berkshire | Uk | British | 155304500001 | |||||
| NEWMEDIA SPARK DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 33 Glasshouse Street W1B 5DG London | 90562530001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MDNX CIG LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdnx Limited | 06. Apr. 2016 | 25 Canada Square Canary Wharf E14 5LQ London 31st Floor England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MDNX CIG LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 10. Jan. 2014 Geliefert am 14. Jan. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 03. Aug. 2012 Geliefert am 09. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 23. Juni 2011 Geliefert am 05. Juli 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 01. Okt. 2010 Geliefert am 15. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of accession | Erstellt am 01. Okt. 2010 Geliefert am 08. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to a security agreement dated 30 september 2010 and | Erstellt am 01. Okt. 2010 Geliefert am 07. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from mdnx group limited to any noteholder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Apr. 2009 Geliefert am 17. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0