HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD

HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06825134
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD?

    • Andere berufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten n.a. (74909) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Holbeche House 437 Shirley Road
    Acocks Green
    B27 7NX Birmingham
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2023

    Welche sind die letzten Einreichungen für HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2023

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2022

    9 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2021

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2020

    10 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2019

    9 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2018

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2017

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2016

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COMERFORD, David Andrew
    The Ridge
    1133 Warwick Road
    B91 3HQ Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    The Ridge
    1133 Warwick Road
    B91 3HQ Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector67128980001
    PEARCE, Mervyn Vincent
    437 Shirley Road
    Acocks Green
    B27 7NX Birmingham
    Holbeche House
    England
    Sekretär
    437 Shirley Road
    Acocks Green
    B27 7NX Birmingham
    Holbeche House
    England
    British114724150001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr David Andrew Comerford
    437 Shirley Road
    Acocks Green
    B27 7NX Birmingham
    Holbeche House
    England
    06. Apr. 2016
    437 Shirley Road
    Acocks Green
    B27 7NX Birmingham
    Holbeche House
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat HERITAGE GRANGE PROPERTIES LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 22. Dez. 2016
    Geliefert am 03. Jan. 2017
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All that the freehold interest in the land and property known as land and buildings on the east side of plowman street, rugby and registered at the land registry with title absolute under title number WK367644 all that the freehold interest in the land and property known as 14 little aston road, aldridge, walsall WS9 0NN and registered at the land registry with title absolute under title number WM667550 all that the freehold interest in the land and property known as 12 little aston road, aldridge, walsall WS9 0NN and registered at the land registry with title absolute under title number WM786469.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Interbay Funding Limited
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 22. Dez. 2016
    Geliefert am 03. Jan. 2017
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All that the freehold interest in the land and property known as land and buildings on the east side of plowman street, rugby and registered at the land registry with title absolute under title number WK367644 all that the freehold interest in the land and property known as 14 little aston road, aldridge, walsall WS9 0NN and registered at the land registry with title absolute under title number WM667550 all that the freehold interest in the land and property known as 12 little aston road, aldridge, walsall WS9 0NN and registered at the land registry with title absolute under title number WM786469.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Interbay Funding Limited
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    Fee agreement second charge
    Erstellt am 19. Aug. 2011
    Geliefert am 23. Aug. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Plot 2 postal number 1, the rowans atherstone warwickshire, north warwickshire t/no WK455004 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • West Register (Investments) Limited
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Apr. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fee agreement second charge
    Erstellt am 05. März 2010
    Geliefert am 09. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    21 mill road rugby warwickshire t/n WK430355, by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • West Register (Investments) Limited
    Transaktionen
    • 09. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Apr. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fee agreement second charge
    Erstellt am 05. März 2010
    Geliefert am 09. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    6 plowman street rugby warwickshire t/n WK367644, by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • West Register (Investments) Limited
    Transaktionen
    • 09. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fee agreement second charge
    Erstellt am 05. März 2010
    Geliefert am 06. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    12 little aston road aldridge walsall west midlands t/no WM786469.by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • West Register (Investments) Limited
    Transaktionen
    • 06. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fee agreement second charge
    Erstellt am 05. März 2010
    Geliefert am 06. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    14 little aston road, aldridge walsall t/no WM667550. By way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • West Register (Investments) Limited
    Transaktionen
    • 06. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 05. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 2 postal no 1 the rowans atherstone t/n WK432870 any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Apr. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 05. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    21 mill road rugby t/n WK430355 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Apr. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 05. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings on the east side of plowman street, rugby, warwickshire t/no WK367644 and any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 2009
    Geliefert am 05. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 12 & 14 little aston road, aldridge, walsall, west midlands t/no WM786469 ans WM667550 and any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 13. Juli 2009
    Geliefert am 16. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0