VIALTUS HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VIALTUS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06904951 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VIALTUS HOLDINGS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich VIALTUS HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Daisy House Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Lancashire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VIALTUS HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für VIALTUS HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Neil Keith Muller als Direktor am 24. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Robinson Riley als Geschäftsführer am 24. Okt. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Daisy House, Suite 1 Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR zum Daisy House Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR am 15. Mai 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. März 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gareth Kirkwood als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VIALTUS HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGLENNON, David Lewis | Sekretär | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | 149406810001 | |||||||
| MULLER, Neil Keith | Geschäftsführer | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | England | British | 252490400001 | |||||
| SMITH, Stephen Alan | Geschäftsführer | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | United Kingdom | British | 161471940001 | |||||
| PORTER, Stewart Charles | Sekretär | Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1FF Uxbridge 5 Middlesex | British | 67037910004 | ||||||
| WOTHERSPOON, Rebecca Jane | Sekretär | Alexandra House W2 1SF London 6a | New Zealander | 134162710001 | ||||||
| DUBENS, Peter Adam Daiches | Geschäftsführer | c/o C/O Oakley Capital Limited Cadogan Gate SW1X 0AS London 3 | Switzerland | British | 153016810001 | |||||
| KIRKWOOD, Gareth Robert | Geschäftsführer | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Suite 1 Lancashire | England | British | 174056480001 | |||||
| PORTER, Stewart Charles | Geschäftsführer | Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1FF Uxbridge 5 Middlesex | British | 67037910004 | ||||||
| RILEY, Anthony John | Geschäftsführer | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Suite 1 Lancashire | England | British | 89230160001 | |||||
| RILEY, Matthew Robinson | Geschäftsführer | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | United Kingdom | British | 178585250001 | |||||
| TILL, David John | Geschäftsführer | Cambridge Road TW1 2HL Twickenham 28 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 133593570001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei VIALTUS HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daisy Telecoms Limited | 06. Apr. 2016 | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat VIALTUS HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental deed | Erstellt am 13. Apr. 2012 Geliefert am 20. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from a chargor to the finance parties, the bi-lateral ancillary lender and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all assets (and all rights in respect thereof), properties, shares, assignments over the accounts, intellectual property, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed relating to a debenture dated 7 june 2010 and | Erstellt am 02. Feb. 2011 Geliefert am 12. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from a chargor to the finance parties, the bi-lateral ancillary lender and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all assets (and all rights in respect thereof), properties, shares, assignments over the accounts, intellectual property, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Juni 2010 Geliefert am 10. Juni 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from a chargor to the finance parties, the bi-lateral ancillary lender and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Jan. 2010 Geliefert am 27. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture accession deed | Erstellt am 09. Juni 2009 Geliefert am 20. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Accession deed to a debenture dated 14 march 2008 and | Erstellt am 09. Juni 2009 Geliefert am 17. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0