BSP REALISATIONS JERSEY LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BSP REALISATIONS JERSEY LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 07026053 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BSP REALISATIONS JERSEY LIMITED?
- (7032) /
Wo befindet sich BSP REALISATIONS JERSEY LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 City Square LS1 2AL Leeds Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BSP REALISATIONS JERSEY LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BARRATTS SHOES PROPERTIES (JERSEY) LIMITED | 22. Sept. 2009 | 22. Sept. 2009 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BSP REALISATIONS JERSEY LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Juli 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BSP REALISATIONS JERSEY LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. Nov. 2012 | 53 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 16. Nov. 2012 | 53 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Juni 2012 | 56 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Juni 2012 | 56 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 6 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 85 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ann Elizabeth Mcgookin als Sekretär am 13. Jan. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed barratts shoes properties (jersey) LIMITED\certificate issued on 23/01/12 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bpl House 880 Harrogate Road Apperley Bridge Bradford West Yorkshire BD10 1NW am 15. Dez. 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian David Field als Geschäftsführer am 07. Dez. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Dr Michael Anthony Ziff am 22. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Edward Max Ziff am 22. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Martin Weaving am 22. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Brian David Field am 22. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Phillip Bott als Geschäftsführer am 12. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Edward Max Ziff am 22. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BSP REALISATIONS JERSEY LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAVING, John Martin | Geschäftsführer | City Square LS1 2AL Leeds 1 Yorkshire | England | British | Director | 137729810001 | ||||
ZIFF, Edward Max | Geschäftsführer | City Square LS1 2AL Leeds 1 Yorkshire | England | British | Director | 2002850001 | ||||
ZIFF, Michael Anthony | Geschäftsführer | City Square LS1 2AL Leeds 1 Yorkshire | England | British | Director | 9804810001 | ||||
MCGOOKIN, Ann Elizabeth | Sekretär | City Square LS1 2AL Leeds 1 Yorkshire | British | 139073520001 | ||||||
BOTT, Richard Phillip | Geschäftsführer | 880 Harrogate Road Apperley Bridge BD10 0NW Bradford Bpl House West Yorkshire England | Uk | British | Chartered Accountant | 43649330001 | ||||
FIELD, Brian David | Geschäftsführer | Harrogate Road Apperley Bridge BD10 1NW Bradford Bpl House 880 West Yorkshire | England | British | Director | 37141570002 |
Hat BSP REALISATIONS JERSEY LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of admission | Erstellt am 27. Apr. 2011 Geliefert am 30. Apr. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing to the bank represented by that sum and credit balances means all of them. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 19 february 2009 and | Erstellt am 05. Jan. 2011 Geliefert am 07. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Okt. 2009 Geliefert am 23. Okt. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 20. Okt. 2009 Geliefert am 23. Okt. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat BSP REALISATIONS JERSEY LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0