AVSAN KNEBWORTH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAVSAN KNEBWORTH LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 07169154
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AVSAN KNEBWORTH LIMITED?

    • Zahnärztliche Praxen (86230) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich AVSAN KNEBWORTH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Bupa Dental Care Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AVSAN KNEBWORTH LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für AVSAN KNEBWORTH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Sarah Louise Ramage als Geschäftsführer am 07. Aug. 2023

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jake Stephen Hockley Wright als Geschäftsführer am 31. Juli 2023

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Faizan Zaheer als Direktor am 29. Nov. 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Barter als Geschäftsführer am 29. Nov. 2022

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark Lee Allan als Direktor am 12. Sept. 2022

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Gabriela Pueyo Roberts als Geschäftsführer am 31. Juli 2022

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    17 SeitenAA

    legacy

    48 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    18 SeitenAA

    legacy

    49 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Ernennung von Dr Peter Alan Crockard als Direktor am 17. Sept. 2020

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Neil William Banton als Geschäftsführer am 17. Sept. 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Stephen Barter als Direktor am 30. Apr. 2020

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Patrick Joseph Conway als Geschäftsführer am 30. Apr. 2020

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von AVSAN KNEBWORTH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Sekretär
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer03155937
    162768400001
    ALLAN, Mark Lee
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    EnglandBritish300174620001
    CROCKARD, Peter Alan, Dr
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    United KingdomNorthern Irish274602410001
    ZAHEER, Faizan, Mr
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    EnglandIrish303034690001
    MANCHESTER SQUARE REGISTRARS LIMITED
    Manchester Square
    W1U 3PY London
    25
    Sekretär
    Manchester Square
    W1U 3PY London
    25
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer4648270
    149745050001
    BANTON, Neil William, Dr
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    United KingdomBritish264993610001
    BARTER, Stephen
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    United KingdomBritish269693010001
    BARTON, Catherine Elizabeth
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    EnglandBritish243693740001
    BRYANT, Robin James, Dr
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    United KingdomBritish169089950001
    CONWAY, Patrick Joseph, Dr
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    United KingdomBritish264993690001
    COYLE, Edward Joseph, Dr
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    United KingdomBritish200405130002
    PREDDY, Steven John, Dr
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    United KingdomBritish250614010001
    PUEYO ROBERTS, Gabriela
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    SpainSpanish254904830001
    RAMAGE, Sarah Louise
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    United KingdomBritish263320220001
    SMITH, Avron Woolf, Dr
    Marsh Road
    LU3 2QF Luton
    31
    England
    Geschäftsführer
    Marsh Road
    LU3 2QF Luton
    31
    England
    United KingdomBritish146809980004
    SMITH, Avron Woolf
    Heathgate
    NW11 7AN London
    28
    England
    Geschäftsführer
    Heathgate
    NW11 7AN London
    28
    England
    EnglandBritish146809980001
    WOOD, Ian David
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    EnglandBritish156407970001
    WRIGHT, Jake Hockley
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    Geschäftsführer
    Vantage Office Park, Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    England
    United KingdomBritish184341770001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AVSAN KNEBWORTH LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    12. Dez. 2019
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer00479564
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Avsan Holdings Limited
    Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care, Vantage Office Park
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Old Gloucester Road
    Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care, Vantage Office Park
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House England
    Registrierungsnummer07021060
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat AVSAN KNEBWORTH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 15. Nov. 2013
    Geliefert am 18. Nov. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    1. the definitions in 1.1 of the debenture also.. 2. the company charges to the lender:. (A) by way of legal mortgage all estates or interests in any freehold, leasehold or commonhold property in england and wales now belonging to the company;. (B) by way of fixed charge:. (I) (to the extent that they are not the subject of an effective mortgage under clause 2.1(a)) all estates or interests in any property in england and wales now or hereafter belonging to the company;. (Ii) all other interests belonging to it in or over land or the proceeds of sale of land and all licences now or in the future held by it to enter on or use land;. (Iii) the benefit of all other agreements relating to each property to which it is or may become a party or otherwise entitled;. (Iv) all plant, machinery and equipment owned by the company and its interest in any plant, machinery and equipment in its possession;. (V) its rights under the appointment of any managing agent of any of the properties;. (Vi) all its rights, title and interest in the insurances;. (Vii) its investments together with all related rights;. (Viii) all its intellectual property;. (Ix) the amount from time to time standing to the credit of any account;. (X) all of its book and other debts and their proceeds and all monies due and owing to it together with the full benefit of all security, collateral instruments and other rights relating to any of the foregoing;. (Xi) all its goodwill and uncalled capital;. (Xii) the benefit of all authorisations held in connection with its business or the use of any charged assets and the right to recover and receive all compensation which may be payable to it in respect of such authorisations or the charged assets;. (Xiii) if and in so far as any assignment in clause 3 shall for any reason be ineffective as an assignment, the assets referred to in that clause; and. (Xiv) by way of floating charge all its undertaking, property and assets both present and future other than any property or assets charged by way of legal mortgage or fixed charge or assigned.. 3. the company assigns to the lender all its rights title and interest both present and future in:. (A) the rental income and all the company's other rights, title and interest under each occupational lease; and. (B) any hedging agreement.. On the unconditional and irrevocable payment and discharge in full of the secured liabilities, the lender will, at the request and cost of the company, reassign the charged assets referred to in this clause to the company.. 4. the lender may by notice to the company convert the floating charge created by this deed into a fixed charge as regards all or any of the company's assets specified in the notice if:. (A) an event of default is continuing; or. (B) the lender considers those assets to be in danger of being seized or sold under distress, attachment, execution, sequestration or other process or to be otherwise in jeopardy.. 5. if, without the prior written consent of the lender or as permitted under this deed:. (A) the company creates any security over any of the charged assets subject to a floating charge under this deed or attempts to do so;. (B) any person levies or attempts to levy any distress, attachment, execution, sequestration or other process against any of the charged assets; or. (C) any steps are taken for the winding up, dissolution, administration or reorganisation of the company,. The floating charge created by this deed over such of the charged assets shall automatically without notice operate and have effect as a fixed charge instantly such event occurs.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 30. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 31. Aug. 2010
    Geliefert am 01. Sept. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0