AGHOCO 1022 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AGHOCO 1022 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 07200489 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AGHOCO 1022 LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich AGHOCO 1022 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AGHOCO 1022 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AGHOCO 1022 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Change of details for Independent Group (Uk) Limited as a person with significant control on 06. Jan. 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Beendigung der Bestellung von Rjp Secretaries Limited als Sekretär am 25. Jan. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Cossey Cosec Services Limited als Sekretär am 25. Jan. 2023 | 2 Seiten | AP04 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom zum 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW am 06. Jan. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||
**Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde aus der Belastung entlassen ** 072004890008 | 5 Seiten | MR05 | ||
**Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde aus der Belastung entlassen ** 4 | 5 Seiten | MR05 | ||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 25. Juli 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Änderung der Details des Direktors für Gold Round Limited am 25. Juli 2022 | 1 Seiten | CH02 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2021 | 7 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 21. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2020 | 8 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Alan Albert Horton als Geschäftsführer am 30. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 29. Juni 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 18. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2019 | 8 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Rjp Secretaries Limited am 09. Aug. 2019 | 1 Seiten | CH04 | ||
Change of details for Independent Group (Uk) Limited as a person with significant control on 09. Aug. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England zum Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL am 12. Aug. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von AGHOCO 1022 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSSEY COSEC SERVICES LIMITED | Sekretär | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 302964180001 | ||||||||||
| PACE, Stuart | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | England | British | 207506130003 | |||||||||
| GOLD ROUND LIMITED | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 149588400001 | ||||||||||
| ROCKETT, Matthew Ian | Sekretär | Swinemoor Lane HU17 0LS Beverley Colonial House East Yorkshire | British | 153274690001 | ||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom |
| 90084920001 | ||||||||||
| RJP SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom |
| 61999120002 | ||||||||||
| BELL, Jonathan | Geschäftsführer | Swinemoor Lane HU17 0LS Beverley Colonial House East Yorkshire | England | British | 123082590001 | |||||||||
| DICKINSON, Louise | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 139480580001 | |||||||||
| HART, Roger | Geschäftsführer | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 105579880001 | |||||||||
| HILLS, Kenneth Cumming | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | United Kingdom | British | 159009950001 | |||||||||
| HORTON, Alan Albert | Geschäftsführer | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | England | British | 182208240001 | |||||||||
| LEE, Peter Francis | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 207608120001 | |||||||||
| LEES, Stuart | Geschäftsführer | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | England | British | 70032700001 | |||||||||
| LLOYD-JONES, Andrew Mark | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 149155620001 | |||||||||
| ROCKETT, Matthew Ian | Geschäftsführer | Swinemoor Lane HU17 0LS Beverley Colonial House East Yorkshire | British | British | 146169560001 | |||||||||
| SMITH, Andrew John | Geschäftsführer | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | United Kingdom | British | 207506140001 | |||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Geschäftsführer | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom |
| 90084920001 | ||||||||||
| INHOCO FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom |
| 900006560001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AGHOCO 1022 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Round Limited | 18. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street W1S 4AW Mayfair 4th Floor London United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Gold Round Limited | 06. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 5th Floor United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Independent Group (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat AGHOCO 1022 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 01. Sept. 2016 Geliefert am 13. Sept. 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Juni 2016 Geliefert am 17. Juni 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 08. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 26 june 2009 | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 08. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 03. Feb. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Juli 2010 Geliefert am 07. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 10. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 05. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0