MEDWAY COMMUNITY HEALTHCARE C.I.C.
Überblick
| Unternehmensname | MEDWAY COMMUNITY HEALTHCARE C.I.C. |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 07275637 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MEDWAY COMMUNITY HEALTHCARE C.I.C.?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich MEDWAY COMMUNITY HEALTHCARE C.I.C.?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Mch House Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Kent United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MEDWAY COMMUNITY HEALTHCARE C.I.C.?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MEDWAY COMMUNITY HEALTHCARE LIMITED | 07. Juni 2010 | 07. Juni 2010 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MEDWAY COMMUNITY HEALTHCARE C.I.C.?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für MEDWAY COMMUNITY HEALTHCARE C.I.C.?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Juni 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 21. Juni 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Juni 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für MEDWAY COMMUNITY HEALTHCARE C.I.C.?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2025 | 111 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2025 mit Aktualisierungen | 34 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2024 | 119 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2024 mit Aktualisierungen | 35 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Ms Louise Parker als Direktor am 16. Mai 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 21. Mai 2024
| 3 Seiten | SH01 | ||
Beendigung der Bestellung von Penelope Jane Smith als Geschäftsführer am 31. März 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2023 | 94 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2023 mit Aktualisierungen | 35 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2022 | 82 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2022 mit Aktualisierungen | 32 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephanie Jane Goad als Geschäftsführer am 31. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2021 | 85 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Bruce John Potter als Direktor am 01. Aug. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Antony Patrick Kildare als Geschäftsführer am 31. Juli 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2021 mit Aktualisierungen | 35 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Dr Diana Hamilton-Fairley als Direktor am 31. März 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Glyn David Griffiths als Geschäftsführer am 31. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2020 | 99 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr John Joseph Niland als Direktor am 27. Jan. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Tony Peter Corkett als Direktor am 27. Jan. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Wendy Cookson als Geschäftsführer am 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 15. Dez. 2020
| 3 Seiten | SH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2020 mit Aktualisierungen | 37 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019 | 74 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von MEDWAY COMMUNITY HEALTHCARE C.I.C.?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARKER, Louise | Sekretär | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | 201315250001 | |||||||
| CORKETT, Tony Peter | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 100576670003 | |||||
| HAMILTON-FAIRLEY, Diana, Dr | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 281602750001 | |||||
| MARTIN, Helen | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 212398680001 | |||||
| NILAND, John Joseph | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 266434250001 | |||||
| PARKER, Louise | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | English | 159156930001 | |||||
| POTTER, Bruce John | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 285978180001 | |||||
| RILEY, Martin | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 117570770002 | |||||
| TYTHERLEIGH, Brian Roy | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 252500260001 | |||||
| WRIGHT, Christopher Jeremy | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 163579320002 | |||||
| SEMPLE, Kirsty | Sekretär | 16-18 The Cross CO7 9QN Wivenhoe Ropery House Essex Uk | British | 158674180001 | ||||||
| CLUMPUS, Lynne | Geschäftsführer | Ambley Green Gillingham Business Park ME8 0NJ Gillingham Unit 5 Kent | England | British | 152270350001 | |||||
| COOKSON, Wendy | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 161788080001 | |||||
| CUNNINGHAM, Helen Mary | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 159699670002 | |||||
| DAVID, Amirtham, Professor | Geschäftsführer | Ambley Green Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0NJ Gillingham Unit 5 Ambley Green Kent Uk | Britain | British | 159161580001 | |||||
| DAVIS, Caroline Gwyneth Amelia | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 202007670001 | |||||
| GEE, Stephen Harold Charles | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 132060180001 | |||||
| GOAD, Stephanie Jane | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 180880720001 | |||||
| GRIFFITHS, Glyn David | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 159158100001 | |||||
| HORN, Peter Richard | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 56102900002 | |||||
| JACOBS, Yomtov Eliezer | Geschäftsführer | Leicester Road Salford M7 4AS Manchester 39a England | England | British | 139215710001 | |||||
| KILDARE, Antony Patrick | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 229266360001 | |||||
| MATHUR, Satish | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 209736280002 | |||||
| OAG, Alistair | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 159161890001 | |||||
| SMITH, Penelope Jane | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 209736240002 | |||||
| STEPHENS, Fiona Anne | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent United Kingdom | England | British | 122431120001 | |||||
| STRONG, Malcolm Roy | Geschäftsführer | Ambley Green Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0NJ Gillingham Unit 5 Kent | United Kingdom | British | 161538450001 | |||||
| STUART, Clive Antony | Geschäftsführer | Ambley Green Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0NJ Gillingham Unit 5 Kent | England | British | 45386740002 | |||||
| WINDIBANK, Oena Marion | Geschäftsführer | Bailey Drive Gillingham Business Park ME8 0PZ Gillingham Mch House Kent Great Britain | United Kingdom | British | 161683780001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für MEDWAY COMMUNITY HEALTHCARE C.I.C.?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 07. Juni 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0