THE ENERGY SOLUTIONS GROUP TOPCO LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THE ENERGY SOLUTIONS GROUP TOPCO LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 07419528 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE ENERGY SOLUTIONS GROUP TOPCO LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich THE ENERGY SOLUTIONS GROUP TOPCO LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ocean Court Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Cheshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE ENERGY SOLUTIONS GROUP TOPCO LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BAS TOPCO LIMITED | 17. Nov. 2010 | 17. Nov. 2010 |
| DE FACTO 1809 LIMITED | 26. Okt. 2010 | 26. Okt. 2010 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE ENERGY SOLUTIONS GROUP TOPCO LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für THE ENERGY SOLUTIONS GROUP TOPCO LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 01. Feb. 2027 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 15. Feb. 2027 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 01. Feb. 2026 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE ENERGY SOLUTIONS GROUP TOPCO LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2026 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Cessation of Sse Contracting Group Limited as a person with significant control on 18. Dez. 2024 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2025 | 9 Seiten | AA | ||
Notification of Sse Contracting Group Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2025 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Notification of Sse Energy Supply Limited as a person with significant control on 18. Dez. 2024 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Sse Contracting Group Limited as a person with significant control on 18. Dez. 2024 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2024 | 9 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2023 | 9 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Graham Atkinson als Sekretär am 04. Apr. 2023 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Mohammed Shehzad Khalid als Sekretär am 04. Apr. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 9 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 9 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 9 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mohammed Shehzad Khalid als Sekretär am 19. Aug. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Brian Dominic Sharma als Sekretär am 19. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 9 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Kevin David Andrew Greenhorn als Geschäftsführer am 01. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Nathan Sanders als Direktor am 03. Mai 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Peter Bradley als Direktor am 12. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von THE ENERGY SOLUTIONS GROUP TOPCO LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATKINSON, Graham | Sekretär | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place England | 307585010001 | |||||||||||
| BRADLEY, Peter | Geschäftsführer | Ocean Court Caspian Road, Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Sse Enterprise Energy Solutions Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 75211210001 | |||||||||
| SANDERS, Nathan | Geschäftsführer | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | England | British | 150936520002 | |||||||||
| KHALID, Mohammed Shehzad | Sekretär | EH28 8PL Newbridge Unit 4 Queen Anne Dr United Kingdom | 261686100001 | |||||||||||
| NIVEN, Veronica Mary | Sekretär | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | 190136650001 | |||||||||||
| SHARMA, Brian Dominic | Sekretär | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | 250773570001 | |||||||||||
| SHARMA, Brian Dominic | Sekretär | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | 208034850001 | |||||||||||
| WADDELL, Archie Stuart | Sekretär | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | 234996250001 | |||||||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Snow Hill EC1A 2AL London 10 England |
| 127984580001 | ||||||||||
| BRACKEN, Ruth | Geschäftsführer | Weald Close CM14 4QU Brentwood 19 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 31216810001 | |||||||||
| DALTON, Stephen George | Geschäftsführer | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire Great Britain | England | British | 156252360001 | |||||||||
| GREENHORN, Kevin David Andrew | Geschäftsführer | 200 Dunkeld Road PH1 3GH Perth Grampian House Scotland | Scotland | British | 145709970001 | |||||||||
| HILLMAN, Christopher Michael | Geschäftsführer | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | England | British | 17572470002 | |||||||||
| HUMPHREYS, Aled Robert | Geschäftsführer | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | United Kingdom | British | 200150330001 | |||||||||
| JENKINS, Robert Ian | Geschäftsführer | 95 Wigmore Street W1U 1FB London Bridgepoint Advisers Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 36230590002 | |||||||||
| LAWSON, Robin Arthur Jordan | Geschäftsführer | 95 Wigmore Street W1U 1FB London Bridgepoint Advisers Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 152514160003 | |||||||||
| LAWSON, Robin Arthur Jordan | Geschäftsführer | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire | England | British | 152514160002 | |||||||||
| LLOYD, Derek Thomas | Geschäftsführer | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire | England | English | 98695040001 | |||||||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Geschäftsführer | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | England | British | 18996670004 | |||||||||
| MCPHILLIMY, James | Geschäftsführer | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | United Kingdom | British | 94397700001 | |||||||||
| NIVEN, Veronica Mary | Geschäftsführer | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire Great Britain | United Kingdom | British | 53122860001 | |||||||||
| PAYNE, Alan Douglas | Geschäftsführer | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire | England | British | 74345940003 | |||||||||
| SAVAGE, Robert Mark | Geschäftsführer | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altricham Ocean Court Cheshire Great Britain | England | British | 113044840003 | |||||||||
| SELKIRK, Roderick Alistair | Geschäftsführer | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire Great Britain | United Kingdom | British | 66607750002 | |||||||||
| SHERIDAN, Richard Brinsley | Geschäftsführer | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | United Kingdom | British | 192888360001 | |||||||||
| SHERIDAN, Richard Brinsley | Geschäftsführer | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire Great Britain | United Kingdom | British | 192888360001 | |||||||||
| TRAVERS SMITH LIMITED | Geschäftsführer | Snow Hill EC1A 2AL London 10 England |
| 147951820001 | ||||||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | Snow Hill EC1A 2AL London 10 England |
| 127984580001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE ENERGY SOLUTIONS GROUP TOPCO LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sse Energy Supply Limited | 18. Dez. 2024 | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Sse Contracting Group Limited | 06. Apr. 2016 | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Sse Contracting Group Limited | 06. Apr. 2016 | RG1 8BU Reading 55 Vastern Road Berkshire England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0