S.O REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameS.O REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 07434105
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von S.O REALISATIONS LIMITED?

    • Sicherheitsdienstleistungen (80200) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich S.O REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Broadgate House Broadgate, Oldham Broadway Business Park
    Chadderton
    OL9 9XA Oldham
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von S.O REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SECURE OPTIONS (UK) LIMITED06. Mai 201106. Mai 2011
    HLW 416 LIMITED09. Nov. 201009. Nov. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für S.O REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Aug. 2013

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 22. Aug. 2013

    21 Seiten2.35B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 22. Aug. 2013

    22 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. März 2013

    18 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    9 Seiten2.16B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    3 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    46 Seiten2.17B

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 31. Aug. 2012

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Commercial House Commercial Street Sheffield South Yorkshire S1 2AT am 09. Aug. 2012

    1 SeitenAD01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2012 bis 31. März 2011

    1 SeitenAA01

    legacy

    8 SeitenMG01

    legacy

    9 SeitenMG01

    legacy

    9 SeitenMG01

    legacy

    14 SeitenMG01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    16. Apr. 2012Clarification This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006

    legacy

    7 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Dez. 2011

    Kapitalaufstellung am 21. Dez. 2011

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    legacy

    9 SeitenMG01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Nov. 2011 bis 31. März 2012

    1 SeitenAA01

    legacy

    5 SeitenMG02

    Aktienspaltung am 18. Aug. 2011

    5 SeitenSH02

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Existing share capital of the company 1 ordinary share of £1 be sub-divided into 100 ordinary shares of £0.01 each having the rights and subject to restrictions contained in the company's articles of association 18/08/2011
    RES13

    Beendigung der Bestellung von John Sykes als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von S.O REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HOVARD, Martin John
    162 Middleton Road
    Royton
    OL2 5LS Oldham
    Lane End Works
    England
    Geschäftsführer
    162 Middleton Road
    Royton
    OL2 5LS Oldham
    Lane End Works
    England
    United KingdomBritishConsultant110275710001
    NICHOLLS, Julian Frederick
    Smiths End Lane
    SG8 8LH Barley
    The Thatched Cottage
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Smiths End Lane
    SG8 8LH Barley
    The Thatched Cottage
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishNone95086050001
    DYSON, Roger Kenneth
    Commercial Street
    S1 2AT Sheffield
    Commercial House
    South Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Commercial Street
    S1 2AT Sheffield
    Commercial House
    South Yorkshire
    England
    United KingdomBritishSolicitor84430830001
    SYKES, John George
    Commercial Street
    S1 2AT Sheffield
    Commercial House
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Commercial Street
    S1 2AT Sheffield
    Commercial House
    South Yorkshire
    EnglandBritishAccountant67867030002

    Hat S.O REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of variation
    Erstellt am 03. Juli 2012
    Geliefert am 18. Juli 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and camwatch limited to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Maven Capital Partners UK LLP
    Transaktionen
    • 18. Juli 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Apr. 2012
    Geliefert am 26. Apr. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and camwatch limited to the beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Julian Frederick Nicholls, Philip John Bunting, Glyn Michael Abba, Michael Collis, James Dainty and John Robertson
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 02. Apr. 2012
    Geliefert am 17. Apr. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or camwatch limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Core Capital LLP as Security Trustee for the Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 30. März 2012
    Geliefert am 12. Apr. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and camwatch limited to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Maven Capital Partners UK LLP
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 30. März 2012
    Geliefert am 16. Apr. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 18. Nov. 2011
    Geliefert am 19. Nov. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bibby Financial Services LTD (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 19. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 24. Mai 2011
    Geliefert am 26. Mai 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Secure Options Group Limited Brightstar Consultants Limited Charlton Doors Limited Leerose Integrated Systems Limited Monitored Solutions Limited Nu-Cam Integrated Systems Limited P.a>T Security Systems Limited Secure by Integrity Limited Secure Options High Security Division Limited Secure Options Holdings Limited Secure Options Limited Watchman Traffic Limited
    Transaktionen
    • 26. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat S.O REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. Sept. 2012Beginn der Verwaltung
    22. Aug. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Whitehouse
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    Praktiker
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    Stephen Gerard Clancy
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praktiker
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0