JUPITER ACQUISITIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | JUPITER ACQUISITIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 07577857 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| JUPITER AQUISITIONS LIMITED | 24. März 2011 | 24. März 2011 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Dez. 2021 | 9 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Huw Griffiths als Geschäftsführer am 02. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY United Kingdom zum 1 More London Place London SE1 2AF am 04. Jan. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Pablo Andres als Direktor am 01. Nov. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Daniel Joseph Guerin als Geschäftsführer am 31. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark Richard Jones am 25. Sept. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Daniel Joseph Guerin am 25. Sept. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Huw Griffiths am 25. Sept. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Morton Fraser Llp St Martin's House 16 st Martins Le Grand London EC1A 4EN zum Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY am 25. Sept. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Change of details for Mobius Wind Holdings Limited as a person with significant control on 25. Sept. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Morton Fraser Secretaries Limited als Sekretär am 25. Sept. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Burness Paull Llp als Sekretär am 25. Sept. 2020 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Daniel Joseph Guerin als Direktor am 01. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mark Richard Jones als Direktor am 01. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Mel Zuydam als Geschäftsführer am 01. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Notification of Mobius Wind Holdings Limited as a person with significant control on 15. Aug. 2019 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Jupiter Acquisitions (Holdings) Limited as a person with significant control on 15. Aug. 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURNESS PAULL LLP | Sekretär | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland |
| 274632090001 | ||||||||||||||
| ANDRES, Pablo | Geschäftsführer | 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh 4th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 276031210001 | |||||||||||||
| JONES, Mark Richard | Geschäftsführer | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | Scotland | British | 254843030001 | |||||||||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Sekretär | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | 201246140001 | |||||||||||||||
| BISSET, Graham Ferguson | Sekretär | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive Northamptonshire United Kingdom | 194566770001 | |||||||||||||||
| CALDER, Samantha Jane | Sekretär | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | British | 75830790003 | ||||||||||||||
| LONG, Jacqueline | Sekretär | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive United Kingdom | 204213400001 | |||||||||||||||
| MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 2 Lister Square Quartermile Two EH3 9GL Edinburgh 5th Floor Scotland |
| 95512800001 | ||||||||||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor England | England | British | 294355310001 | |||||||||||||
| BOYD, Gordon Alexander | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | England | British | 148856600001 | |||||||||||||
| BROWN, Katerina | Geschäftsführer | St Martin's House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | Scotland | British | 232165890001 | |||||||||||||
| GIBBINS, Stewart Charles | Geschäftsführer | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor England | United Kingdom | British | 148918290002 | |||||||||||||
| GREGSON, Paul Jonathan | Geschäftsführer | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | England | British | 154908310001 | |||||||||||||
| GRIFFITHS, David Huw | Geschäftsführer | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | United Kingdom | British | 177733400003 | |||||||||||||
| GUERIN, Daniel Joseph | Geschäftsführer | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | England | Irish | 210311660001 | |||||||||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Geschäftsführer | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | Uk | British | 93743250007 | |||||||||||||
| HINTON, Thomas Edward | Geschäftsführer | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 238940970001 | |||||||||||||
| LEE, Andrew William | Geschäftsführer | St. Martin's House 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp United Kingdom | United Kingdom | British | 87527870001 | |||||||||||||
| MACHIELS, Eric Philippe Marianne | Geschäftsführer | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | England | Belgian | 125748990002 | |||||||||||||
| MACKENZIE, Scott Leitch | Geschäftsführer | St Martin's House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | 277478140001 | |||||||||||||
| NAGLE, Michael | Geschäftsführer | St Martin's House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | 29436380007 | |||||||||||||
| PICKERING, Stephen Shane | Geschäftsführer | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 198076630001 | |||||||||||||
| WALTERS, Mark Alan | Geschäftsführer | Victoria Embankment EC4Y 0JP London 60 United Kingdom | England | British | 317548840001 | |||||||||||||
| WINTER, Robert Guy Stewart | Geschäftsführer | 10 St Paul's Churchyard EC4M 8AL London Condor House England | England | British | 158816660001 | |||||||||||||
| ZUYDAM, David Mel | Geschäftsführer | St Martin's House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | England | British | 259635370001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobius Wind Holdings Limited | 15. Aug. 2019 | 133-137 Alexandra Road Wimbledon SW19 7JY London Connect House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Jupiter Acquisitions (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat JUPITER ACQUISITIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 18. Dez. 2017 Geliefert am 20. Dez. 2017 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 15. Dez. 2017 Geliefert am 29. Dez. 2017 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 10. Okt. 2013 Geliefert am 17. Okt. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 10. Okt. 2013 Geliefert am 17. Okt. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 10. Okt. 2013 Geliefert am 17. Okt. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 09. Okt. 2013 Geliefert am 11. Okt. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 09. Okt. 2013 Geliefert am 11. Okt. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Intellectual property. The chargor charges, by way of first fixed charge, all of the rights which it now has and all of the rights which it obtains at any time in the future in intellectual property.. Intellectual property means:. (A) all copyright (including rights in computer software), patents, trade marks, trade names, service marks, business names (including internet domain names), design rights, database rights, semi-conductor topography rights and all other intellectual property or similar proprietary rights (whether registered or not and including applications to register or rights to apply for registration) which, in each case, are of a type which are not disposed of in the ordinary course of trading;. (B) any intellectual property that supplements or replaces intellectual property described in (a) above; and. (C) any intellectual property acquired after the date of this deed which is designated as intellectual property by a chargor and the security agent at or about the time of its acquisition. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of pledge | Erstellt am 14. Apr. 2011 Geliefert am 03. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from minsca windfarm (scotland) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The secured assets being the existing shares, the further shares and the related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of pledge | Erstellt am 14. Apr. 2011 Geliefert am 21. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The secured assets being the existing shares, the future shares and the related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of pledge | Erstellt am 14. Apr. 2011 Geliefert am 21. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from dalswinton windfarm (scotland) limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The secured assets being the existing shares, the future shares and the related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 14. Apr. 2011 Geliefert am 19. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge any shares and any rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 14. Apr. 2011 Geliefert am 19. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge the shares and any rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 14. Apr. 2011 Geliefert am 19. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares in slieve divena wind farm limited and any rights including dividends, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Apr. 2011 Geliefert am 15. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from minsca windfarm (scotland) limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, all copyright, plant and machinery, the specified key accounts. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Apr. 2011 Geliefert am 15. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, all copyright, plant and machinery, the specified key accounts. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Apr. 2011 Geliefert am 15. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from dalswinton windfarm (scotland) limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, all copyright, plant and machinery, the specified key accounts. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat JUPITER ACQUISITIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0