TOP LASER LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTOP LASER LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 07589306
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TOP LASER LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich TOP LASER LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o WATKIN JONES & SON LIMITED
    Llandygai Industrial Estate
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Gwynedd
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TOP LASER LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für TOP LASER LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Beendigung der Bestellung von Mark Watkin Jones als Geschäftsführer am 02. Jan. 2019

    1 SeitenTM01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Watkin Jones am 22. Juni 2017

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2016

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 04. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Glyn Watkin Jones als Geschäftsführer am 12. Feb. 2016

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Apr. 2015

    Kapitalaufstellung am 08. Apr. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 09. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    15 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    25 SeitenMG01

    Beschlüsse

    Resolutions
    9 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 ca 2006 and credit agreement 25/05/2012
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von TOP LASER LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BYROM, Philip Martin
    c/o Watkin Jones & Son Limited
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Llandygai Industrial Estate
    Gwynedd
    Wales
    Sekretär
    c/o Watkin Jones & Son Limited
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Llandygai Industrial Estate
    Gwynedd
    Wales
    161499030001
    BYROM, Philip Martin
    c/o Watkin Jones & Son Limited
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Llandygai Industrial Estate
    Gwynedd
    Wales
    Geschäftsführer
    c/o Watkin Jones & Son Limited
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Llandygai Industrial Estate
    Gwynedd
    Wales
    United KingdomBritish108768790002
    STEPHENS, Graham Robertson
    Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    16
    Wales
    Geschäftsführer
    Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    16
    Wales
    WalesBritish100220980001
    WATKIN JONES, Glyn
    c/o Watkin Jones & Son Limited
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Llandygai Industrial Estate
    Gwynedd
    Wales
    Geschäftsführer
    c/o Watkin Jones & Son Limited
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Llandygai Industrial Estate
    Gwynedd
    Wales
    WalesWelsh77892600001
    WATKIN JONES, Mark
    Llandygai Industrial Estate
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Units 21-22
    Wales
    Geschäftsführer
    Llandygai Industrial Estate
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Units 21-22
    Wales
    WalesBritish73218710007

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TOP LASER LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Newmark Developments Limited
    Llandygai Industrial Estate
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Units 21-22
    Gwynedd
    Wales
    04. Apr. 2017
    Llandygai Industrial Estate
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Units 21-22
    Gwynedd
    Wales
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland/Wales
    RechtsgrundlageCompany Law
    RegistrierungsortEngland/Wales
    Registrierungsnummer05614426
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat TOP LASER LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2012
    Geliefert am 26. Juni 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land k/a land and buildings on the east side of wincolmlee kingston upon hull t/no HS184768, f/h land k/a belmont wharf wincolmlee hull t/no HS201080 and f/h land k/a land and buildings at wincolmlee kingston upon hull t/no HS245309 (for full list of properties charged please see form MG01) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Nov. 2011
    Geliefert am 03. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a magenta house 85 whitechapel road london t/no AGL238547 and f/h land and buildings k/a land at the back of 57 and 59 whitechapel road london t/no AGL238548 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Sept. 2011
    Geliefert am 24. Sept. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings whitechapel technology centre 75 whitehcapel road london forming part of the land t/no NGL53477. F/h land and buildings as land at the back of 57 and 59 whitechapel road london formimng the land t/no NGL424187 and. F/h land and buildings as 57/59 whitechapel road stepney forming part of the land t/no EGL438425 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. Sept. 2011
    Geliefert am 24. Sept. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juli 2011
    Geliefert am 30. Juli 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juli 2011
    Geliefert am 30. Juli 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings at greatorex street, london and to the north side of whitechapel road and the rear of 57 and 59 whitechapel road, london. F/h land and buildings k/a whitechapel technology centre, 75 whitechapel road, london part t/no NGL53477. F/h land and buildings k/a land at the back of 57 and 59 whitechapel road, london t/no NGL424187. F/h land and buildings k/a 57/59 whitechapel road, stepney part t/no EGL438425. Together with all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0