MMCG (CCH) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMMCG (CCH) LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 07590616
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MMCG (CCH) LIMITED?

    • Betreuungseinrichtungen für ältere und behinderte Menschen (87300) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich MMCG (CCH) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Westcourt
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MMCG (CCH) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    COUNTRYWIDE CARE HOMES LIMITED06. Juni 201106. Juni 2011
    PRINCIPLE CARE HOMES LIMITED04. Apr. 201104. Apr. 2011

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MMCG (CCH) LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Sept. 2024
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Juni 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2023

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für MMCG (CCH) LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis04. Apr. 2025
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung18. Apr. 2025
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis04. Apr. 2024
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für MMCG (CCH) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Ernennung von Mr Farouk Mangera als Direktor am 08. Juli 2024

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Mark Walker als Direktor am 08. Juli 2024

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Jordan Burns als Direktor am 08. Juli 2024

    2 SeitenAP01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2023

    39 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von James Dinwoodie als Geschäftsführer am 13. Mai 2024

    1 SeitenTM01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed countrywide care homes LIMITED\certificate issued on 02/05/24
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name02. Mai 2024

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 30. Apr. 2024

    RES15

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Ermächtigung zum Erwerb einer bestimmten Anzahl von Aktien

    RES09
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    25 SeitenMA

    Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 19. Apr. 2024

    • Kapital: GBP 340.09900
    6 SeitenSH06

    Eigenkapitalrückkauf.

    4 SeitenSH03

    Notification of Mmcg Topco Holdings Ltd as a person with significant control on 19. Apr. 2024

    2 SeitenPSC02

    Cessation of Philip John Burgan as a person with significant control on 19. Apr. 2024

    1 SeitenPSC07

    Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 075906160028 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Christina Chapman als Geschäftsführer am 30. Sept. 2023

    1 SeitenTM01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    25 SeitenMA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Sub division 21/06/2023
    RES13

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2022

    41 SeitenAA

    legacy

    41 SeitenPARENT_ACC

    Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr James Dinwoodie als Direktor am 01. Feb. 2023

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von James Edward Burgan als Geschäftsführer am 16. Jan. 2023

    1 SeitenTM01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2021

    37 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Daren Robert Harris als Geschäftsführer am 08. Dez. 2022

    1 SeitenTM01

    Zweite Einreichung der Bestätigungserklärung vom 04. Apr. 2022

    5 SeitenRP04CS01

    Wer sind die Geschäftsführer von MMCG (CCH) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BURGAN, Lynne Frances
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director3311690001
    BURGAN, Philip John
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector2140090001
    BURNS, Jordan
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director324858200001
    LOCK, Jason David
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector253556710001
    MANGERA, Farouk
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director324859900001
    WALKER, Mark
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director324859660001
    WALSH, Paul Michael
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector318138970001
    WOMACK, Christopher John
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishBusiness Development Director138694680003
    WRIGHT, John Charles
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector111401500003
    FAGAN, Peter Gervais
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    Sekretär
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    258042380001
    BALL, Christopher
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector78363650002
    BURGAN, James Edward
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCommercial Director124506000003
    CHAPMAN, Christina
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    ScotlandBritishDirector291398390001
    CRADDOCK, Victoria
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishOperations Director138198100003
    DELIC, Dzenana
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishHr Director156904780003
    DINWOODIE, James Kenneth
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChief Finance Officer304987630001
    FAGAN, Peter Gervais
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector150917160001
    HARRIS, Daren Robert
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector282357220001
    MYERS, Nigel
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    EnglandBritishChief Financial Officer122921990001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MMCG (CCH) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    England
    19. Apr. 2024
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer13863881
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Mr Philip John Burgan
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    30. Juni 2016
    Gelderd Road
    LS12 6DB Leeds
    Westcourt
    West Yorkshire
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat MMCG (CCH) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 02. Nov. 2021
    Geliefert am 03. Nov. 2021
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Fdc Debt LP Acting by Its General Partner, Fdc General Partner Limited
    Transaktionen
    • 03. Nov. 2021Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 21. Dez. 2018
    Geliefert am 31. Dez. 2018
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Dez. 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 12. März 2024Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 19. Juni 2013
    Geliefert am 26. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 30. Jan. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge of leasehold interest
    Erstellt am 23. Nov. 2012
    Geliefert am 29. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All that property known as ARD mhacha house, desart lane lower, armagh f/no AR116981L together with any goodwill, all guarantees, by way of floating charge all unattached plant, machinery, chattels and any goods see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge of leasehold interest
    Erstellt am 23. Nov. 2012
    Geliefert am 29. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All that property known as ashbrooke nursing home. 2A ashbourne manor, chanterhill, enniskillen, country fermanagh f/no FE85954L and geanann care home, 31 ballygawley road, dungannon, county tyrone f/no TY86362L together with any goodwill, all guarantees, by way of floating charge all unattached plant, machinery, chattels and any goods see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 19. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south east side of the avenue, dallington, northampton t/no NN180381 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • K/S Northampton
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Standard security executed on 31 october 2011
    Erstellt am 18. Nov. 2011
    Geliefert am 26. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects registered in scotland under t/no LAN199030 in respect of the subjects k/a parksprings orbiston care home java street mother well together with fittings and fixtures and the goodwill see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security executed on 31 october 2011
    Erstellt am 18. Nov. 2011
    Geliefert am 23. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Interest in the lease in respect of parksprings (orbiston) care home, jave street, motherwell t/no LAN199030.
    Berechtigte Personen
    • Dolphin Properties Scotland Limited
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security executed on 31 october 2011
    Erstellt am 17. Nov. 2011
    Geliefert am 26. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects registered in scotland under t/no STG59788 in respect of the subjects k/a thorntree mews nursing home 17 arnot hill falkirk together with fittings and fixtures and the goodwill see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security executed on 31 october 2011
    Erstellt am 17. Nov. 2011
    Geliefert am 23. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Interest in lease in respect of thorntree mews nursing home, arnot hill, falkirk t/no STG59788.
    Berechtigte Personen
    • Dolphin Properties Scotland Limited
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security executed on 31 october 2011
    Erstellt am 16. Nov. 2011
    Geliefert am 26. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects registered in scotland under t/no AYR85550 in respect of the subjects k/a glennie house william mccomb court auchinleck cumnock together with fittings and fixtures and the goodwill see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security executed on 31 october 2011
    Erstellt am 16. Nov. 2011
    Geliefert am 26. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects registered in scotland under t/no STG59787 in respect of the subjects k/a wallace view care home 77 westhaugh road stirling together with the fittings and fixtures and the goodwill see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security executed on 31 october 2011
    Erstellt am 16. Nov. 2011
    Geliefert am 23. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Interest in the lease inrespect of wallace view care home, 77 westhaugh road, stirling t/no STG59787.
    Berechtigte Personen
    • Dolphin Properties Scotland Limited
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security executed on 31 october 2011
    Erstellt am 15. Nov. 2011
    Geliefert am 26. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects registered under t/no LAN199172 in respect of the subjects k/a parksprings calder care home frood street motherwell together with fittings and fixtures and the goodwill see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security executed on 31 october 2011
    Erstellt am 15. Nov. 2011
    Geliefert am 26. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects registered in scotland under t/no AYR85850 in respect of the subjects k/a torrance lodge nursing home kilmarnock together with fittings and fixtures goodwill see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security executed on 31 october 2011
    Erstellt am 15. Nov. 2011
    Geliefert am 23. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Interest in lease in respect of parksprings (calder) care home, frood street, motherwell t/no LAN199172.
    Berechtigte Personen
    • Dolphin Properties Scotland Limited
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Nov. 2011
    Geliefert am 19. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Clumber court, bolham lane, retford, nottinghamshire t/no NT326903; all fixtures, plant machinery and equipment, proceeds of sale, the shares, every insurance policy, all guarantees, warranties. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 19. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 02. Nov. 2011
    Geliefert am 10. Nov. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The acorn care centre, whalley new road, blackburn t/no LAN17494 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • K/S Rowans (The Chargee)
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Security agreement
    Erstellt am 02. Nov. 2011
    Geliefert am 10. Nov. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Gateford hill nursing home, gateford hill, gateford, worksop t/no NT410997 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • K/S Gateford Hill (The Chargee)
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Security agreement
    Erstellt am 31. Okt. 2011
    Geliefert am 12. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property known as belmont house nursing home, high street, strabeck, harrogate, t/no: NYK346521 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kendall Property Limited
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Okt. 2011
    Geliefert am 05. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Belmont house nursing home, high street, starbeck, harrogate, t/no NYK346521 and the proceeds of sale, all compensation or grants, by way of floating security all its property and assets, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Okt. 2011
    Geliefert am 05. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Waneford house, tenter balk lane, adwich-le-street, doncaster, t/no SYK508998 and the proceeds of sale, all compensation or grants, by way of floating security all its property and assets, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Okt. 2011
    Geliefert am 05. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    St martins care centre, oakhill park, liverpool t/no MS541702 and the proceeds of sale, all compensation or grants, by way of floating security all its property and assets, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Okt. 2011
    Geliefert am 05. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south east side of the avenue, dallington, northampton t/no NN180381 and the proceeds of sale, all compensation or grants, by way of floating security all its property and assets, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Okt. 2011
    Geliefert am 05. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The acorn care centre, whalley new road, blackburn t/no LAN17494 and the proceeds of sale, all compensation or grants, by way of floating security all its property and assets, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0