MMCG (CCH) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MMCG (CCH) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 07590616 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MMCG (CCH) LIMITED?
- Betreuungseinrichtungen für ältere und behinderte Menschen (87300) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich MMCG (CCH) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Westcourt Gelderd Road LS12 6DB Leeds West Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MMCG (CCH) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
COUNTRYWIDE CARE HOMES LIMITED | 06. Juni 2011 | 06. Juni 2011 |
PRINCIPLE CARE HOMES LIMITED | 04. Apr. 2011 | 04. Apr. 2011 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MMCG (CCH) LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Sept. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für MMCG (CCH) LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 04. Apr. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 18. Apr. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 04. Apr. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für MMCG (CCH) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernennung von Mr Farouk Mangera als Direktor am 08. Juli 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Mark Walker als Direktor am 08. Juli 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Jordan Burns als Direktor am 08. Juli 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2023 | 39 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Dinwoodie als Geschäftsführer am 13. Mai 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed countrywide care homes LIMITED\certificate issued on 02/05/24 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 25 Seiten | MA | ||||||||||||||
Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 19. Apr. 2024
| 6 Seiten | SH06 | ||||||||||||||
Eigenkapitalrückkauf. | 4 Seiten | SH03 | ||||||||||||||
Notification of Mmcg Topco Holdings Ltd as a person with significant control on 19. Apr. 2024 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation of Philip John Burgan as a person with significant control on 19. Apr. 2024 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 075906160028 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christina Chapman als Geschäftsführer am 30. Sept. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 25 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2022 | 41 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 41 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr James Dinwoodie als Direktor am 01. Feb. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Edward Burgan als Geschäftsführer am 16. Jan. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2021 | 37 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Daren Robert Harris als Geschäftsführer am 08. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Zweite Einreichung der Bestätigungserklärung vom 04. Apr. 2022 | 5 Seiten | RP04CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MMCG (CCH) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURGAN, Lynne Frances | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire United Kingdom | England | British | Company Director | 3311690001 | ||||
BURGAN, Philip John | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire United Kingdom | England | British | Director | 2140090001 | ||||
BURNS, Jordan | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire | England | British | Company Director | 324858200001 | ||||
LOCK, Jason David | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 253556710001 | ||||
MANGERA, Farouk | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire | England | British | Company Director | 324859900001 | ||||
WALKER, Mark | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire | England | British | Company Director | 324859660001 | ||||
WALSH, Paul Michael | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire | England | British | Director | 318138970001 | ||||
WOMACK, Christopher John | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire United Kingdom | England | British | Business Development Director | 138694680003 | ||||
WRIGHT, John Charles | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire | England | British | Director | 111401500003 | ||||
FAGAN, Peter Gervais | Sekretär | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire | 258042380001 | |||||||
BALL, Christopher | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 78363650002 | ||||
BURGAN, James Edward | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire United Kingdom | England | British | Commercial Director | 124506000003 | ||||
CHAPMAN, Christina | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire | Scotland | British | Director | 291398390001 | ||||
CRADDOCK, Victoria | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire United Kingdom | England | British | Operations Director | 138198100003 | ||||
DELIC, Dzenana | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire United Kingdom | England | British | Hr Director | 156904780003 | ||||
DINWOODIE, James Kenneth | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire | United Kingdom | British | Chief Finance Officer | 304987630001 | ||||
FAGAN, Peter Gervais | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire United Kingdom | England | British | Director | 150917160001 | ||||
HARRIS, Daren Robert | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire | England | British | Director | 282357220001 | ||||
MYERS, Nigel | Geschäftsführer | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire | England | British | Chief Financial Officer | 122921990001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MMCG (CCH) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mmcg Topco Holdings Ltd | 19. Apr. 2024 | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Philip John Burgan | 30. Juni 2016 | Gelderd Road LS12 6DB Leeds Westcourt West Yorkshire | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat MMCG (CCH) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 02. Nov. 2021 Geliefert am 03. Nov. 2021 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 21. Dez. 2018 Geliefert am 31. Dez. 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 19. Juni 2013 Geliefert am 26. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge of leasehold interest | Erstellt am 23. Nov. 2012 Geliefert am 29. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All that property known as ARD mhacha house, desart lane lower, armagh f/no AR116981L together with any goodwill, all guarantees, by way of floating charge all unattached plant, machinery, chattels and any goods see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge of leasehold interest | Erstellt am 23. Nov. 2012 Geliefert am 29. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All that property known as ashbrooke nursing home. 2A ashbourne manor, chanterhill, enniskillen, country fermanagh f/no FE85954L and geanann care home, 31 ballygawley road, dungannon, county tyrone f/no TY86362L together with any goodwill, all guarantees, by way of floating charge all unattached plant, machinery, chattels and any goods see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 06. Dez. 2011 Geliefert am 19. Dez. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land and buildings on the south east side of the avenue, dallington, northampton t/no NN180381 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security executed on 31 october 2011 | Erstellt am 18. Nov. 2011 Geliefert am 26. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects registered in scotland under t/no LAN199030 in respect of the subjects k/a parksprings orbiston care home java street mother well together with fittings and fixtures and the goodwill see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security executed on 31 october 2011 | Erstellt am 18. Nov. 2011 Geliefert am 23. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Interest in the lease in respect of parksprings (orbiston) care home, jave street, motherwell t/no LAN199030. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security executed on 31 october 2011 | Erstellt am 17. Nov. 2011 Geliefert am 26. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects registered in scotland under t/no STG59788 in respect of the subjects k/a thorntree mews nursing home 17 arnot hill falkirk together with fittings and fixtures and the goodwill see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security executed on 31 october 2011 | Erstellt am 17. Nov. 2011 Geliefert am 23. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Interest in lease in respect of thorntree mews nursing home, arnot hill, falkirk t/no STG59788. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security executed on 31 october 2011 | Erstellt am 16. Nov. 2011 Geliefert am 26. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects registered in scotland under t/no AYR85550 in respect of the subjects k/a glennie house william mccomb court auchinleck cumnock together with fittings and fixtures and the goodwill see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security executed on 31 october 2011 | Erstellt am 16. Nov. 2011 Geliefert am 26. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects registered in scotland under t/no STG59787 in respect of the subjects k/a wallace view care home 77 westhaugh road stirling together with the fittings and fixtures and the goodwill see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security executed on 31 october 2011 | Erstellt am 16. Nov. 2011 Geliefert am 23. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Interest in the lease inrespect of wallace view care home, 77 westhaugh road, stirling t/no STG59787. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security executed on 31 october 2011 | Erstellt am 15. Nov. 2011 Geliefert am 26. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects registered under t/no LAN199172 in respect of the subjects k/a parksprings calder care home frood street motherwell together with fittings and fixtures and the goodwill see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security executed on 31 october 2011 | Erstellt am 15. Nov. 2011 Geliefert am 26. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects registered in scotland under t/no AYR85850 in respect of the subjects k/a torrance lodge nursing home kilmarnock together with fittings and fixtures goodwill see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security executed on 31 october 2011 | Erstellt am 15. Nov. 2011 Geliefert am 23. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Interest in lease in respect of parksprings (calder) care home, frood street, motherwell t/no LAN199172. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 14. Nov. 2011 Geliefert am 19. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Clumber court, bolham lane, retford, nottinghamshire t/no NT326903; all fixtures, plant machinery and equipment, proceeds of sale, the shares, every insurance policy, all guarantees, warranties. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 02. Nov. 2011 Geliefert am 10. Nov. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The acorn care centre, whalley new road, blackburn t/no LAN17494 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 02. Nov. 2011 Geliefert am 10. Nov. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Gateford hill nursing home, gateford hill, gateford, worksop t/no NT410997 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 31. Okt. 2011 Geliefert am 12. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property known as belmont house nursing home, high street, strabeck, harrogate, t/no: NYK346521 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Okt. 2011 Geliefert am 05. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Belmont house nursing home, high street, starbeck, harrogate, t/no NYK346521 and the proceeds of sale, all compensation or grants, by way of floating security all its property and assets, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Okt. 2011 Geliefert am 05. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Waneford house, tenter balk lane, adwich-le-street, doncaster, t/no SYK508998 and the proceeds of sale, all compensation or grants, by way of floating security all its property and assets, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Okt. 2011 Geliefert am 05. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben St martins care centre, oakhill park, liverpool t/no MS541702 and the proceeds of sale, all compensation or grants, by way of floating security all its property and assets, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Okt. 2011 Geliefert am 05. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land and buildings on the south east side of the avenue, dallington, northampton t/no NN180381 and the proceeds of sale, all compensation or grants, by way of floating security all its property and assets, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Okt. 2011 Geliefert am 05. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The acorn care centre, whalley new road, blackburn t/no LAN17494 and the proceeds of sale, all compensation or grants, by way of floating security all its property and assets, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0