GRACECHURCH UTG NO. 416 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GRACECHURCH UTG NO. 416 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 07702351 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GRACECHURCH UTG NO. 416 LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich GRACECHURCH UTG NO. 416 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5th Floor 40 Gracechurch Street EC3V 0BT London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GRACECHURCH UTG NO. 416 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CANOPIUS CAPITAL ELEVEN LIMITED | 12. Juli 2011 | 12. Juli 2011 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRACECHURCH UTG NO. 416 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GRACECHURCH UTG NO. 416 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Dez. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mark John Tottman als Direktor am 31. Juli 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Richard Holt Evans als Geschäftsführer am 31. Juli 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Okt. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Sinclair Meyer als Geschäftsführer am 23. Apr. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Patrick Duffy als Geschäftsführer am 23. Apr. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Laurie Davison als Geschäftsführer am 23. Apr. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Cessation of Canopius Holdings Uk Limited as a person with significant control on 23. Apr. 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Ernennung von Jeremy Richard Holt Evans als Direktor am 23. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Nomina Plc als Direktor am 23. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Ernennung von Hampden Legal Plc als Sekretär am 23. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Gallery 9 One Lime Street London EC3M 7HA zum 5th Floor 40 Gracechurch Street London EC3V 0BT am 30. Apr. 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Notification of Nomina Services Limited as a person with significant control on 23. Apr. 2021 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GRACECHURCH UTG NO. 416 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMPDEN LEGAL PLC | Sekretär | Great Hampden HP16 9RD Great Missenden Hampden House Bucks England |
| 56301100002 | ||||||||||
TOTTMAN, Mark John | Geschäftsführer | 40 Gracechurch Street EC3V 0BT London 5th Floor England | United Kingdom | British | Underwriting Agent | 72513380002 | ||||||||
NOMINA PLC | Geschäftsführer | 40 Gracechurch Street EC3V 0BT London 5th Floor England |
| 81968410003 | ||||||||||
CORMACK, Adrianne Helen Marie | Sekretär | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 United Kingdom | 161515450001 | |||||||||||
DAOUD-O'CONNELL, Mariana, Mrs. | Sekretär | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 | 234503050001 | |||||||||||
DONOVAN, Paul | Sekretär | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 United Kingdom | 171250510001 | |||||||||||
GREENFIELD, James William | Sekretär | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 United Kingdom | 179050530001 | |||||||||||
MARSHALL, Joanne, Ms. | Sekretär | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 | 261467280001 | |||||||||||
COOPER, Paul David | Geschäftsführer | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 178892050001 | ||||||||
CRIPPS, Richard Hugh | Geschäftsführer | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 56275630001 | ||||||||
DAVIES, Stuart Robert | Geschäftsführer | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 | England | British | Company Director | 102224810002 | ||||||||
DAVISON, Laurie Esther, Ms. | Geschäftsführer | 40 Gracechurch Street EC3V 0BT London 5th Floor England | England | Irish | Company Director | 304127990001 | ||||||||
DUFFY, Michael Patrick | Geschäftsführer | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 United Kingdom | England | British | Company Director | 171446030001 | ||||||||
EVANS, Jeremy Richard Holt | Geschäftsführer | 40 Gracechurch Street EC3V 0BT London 5th Floor England | England | British | Company Director | 247750500001 | ||||||||
HARDEN, Robert John, Mr. | Geschäftsführer | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 | United Kingdom | British | Company Director | 135026050001 | ||||||||
LAW, Robert David | Geschäftsführer | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 50487940002 | ||||||||
MANNING, Stephen Trevor | Geschäftsführer | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 191001170001 | ||||||||
MEYER, Nigel Sinclair, Mr. | Geschäftsführer | 40 Gracechurch Street EC3V 0BT London 5th Floor England | United Kingdom | British | Company Director | 306117510001 | ||||||||
WATSON, Michael Clive | Geschäftsführer | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 78617840010 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GRACECHURCH UTG NO. 416 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomina Services Limited | 23. Apr. 2021 | 40 Gracechurch Street EC3V 0BT London 5th Floor England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Canopius Holdings Uk Limited | 31. Dez. 2017 | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Canopius Holdings Uk Limited | 06. Apr. 2016 | One Lime Street EC3M 7HA London Gallery 9 United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für GRACECHURCH UTG NO. 416 LIMITED?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
31. Dez. 2017 | 31. Dez. 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat GRACECHURCH UTG NO. 416 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deposit trust deed (third party deposit) (gen) (10) | Erstellt am 15. März 2013 Geliefert am 27. März 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the future profits of the underwriting business of the company at lloyd’s subject to any prior charge contained in the premiums trust deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Lloyd’s canadian trust deed dated 25 may 2001 (the trust deed) | Erstellt am 01. Jan. 2012 Geliefert am 17. Jan. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the present and future assets of the company comprised in the company’s canadian trust fund constituted under and pursuant to the lloyd’s canadian trust deed full particulars of which assets are set out in clause 3 of and schedule 2 to the lloyd’s canadian trust deed. See image for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Amendment and restatement lloyd’s american instrument 1995 (general business for corporate members) (the 1995 american instrument (corporate members)) dated 31 july 1995 and amended on 28 december 2001, 1 april 2001, 1 august 2001, 13 february 2002, 27 september 2007 and 24 march 2009 | Erstellt am 01. Jan. 2012 Geliefert am 17. Jan. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the present and future assets of the company comprised in the company’s dollar trust fund constituted under and pursuant to the 1995 american instrument (corporate member) full particulars of which assets are set out in clause 3 of and schedule 2 to the 1995 american instrument (corporate members). See image for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Lloyd’s asia (singapore policies) instrument 2002 (general business of all underwriting members) (the singapore policies instrument) dated 13 february 2002 | Erstellt am 01. Jan. 2012 Geliefert am 17. Jan. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All present and future assets of the company comprised in the company’s singapore policies trust fund constituted under and pursuant to the singapore policies instrument, full particulars of which assets are set out in clause 3 of and schedule to 2 the singapore policies instrument. See image for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Lloyd’s asia (offshore policies) instrument 2002 (general business of all underwriting members) (the offshore policies instrument) dated 13 february 2002 | Erstellt am 01. Jan. 2012 Geliefert am 17. Jan. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All present and future assets of the company comprised in the company’s offshore policies trust fund constituted under and pursuant to the offshore policies instrument, full particulars of which assets are set out in clause 3 of and schedule to 2 the offshore policies instrument. See image for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Lloyd’s premium trust deed (general business) (the trust deed) | Erstellt am 01. Jan. 2012 Geliefert am 17. Jan. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All present and future assets of the company comprised in the trust fund constituted under and pursuant to the trust deed full particulars of which assets are set out in clause 2 of and schedule 2 to the trust deed. See image for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Lloyd’s security & trust deed (interavailable – corporate member version) (letter of credit and guarantee) (the trust deed) made between the LLP, flectat limited (the “2011 member”) and the society incorporated by lloyd’s act 1871 by the name of lloyd’s (the society) | Erstellt am 01. Dez. 2011 Geliefert am 06. Dez. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben As security for the secured obligations referred to in paragraph 1 under “amounts secured”, all moneys or other property at any time paid or transferred to or under the direct or indirect control of the trustees (being the society and the other trustees for the time being of the trusts created by the trust deed) and all accumulations of income and the investments and other property for the time being representing the same. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0