IREMIS HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameIREMIS HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 07702564
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von IREMIS HOLDINGS LIMITED?

    • Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich IREMIS HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Hackwood Secretaries Limited
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von IREMIS HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GULMAR ENERGY LIMITED12. Juli 201112. Juli 2011

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IREMIS HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für IREMIS HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Hackwood Secretaries Limited als Sekretär am 17. Okt. 2016

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Ben Gujral als Geschäftsführer am 31. Aug. 2016

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 07. Aug. 2015

    • Kapital: USD 100
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Burwell Reed am 12. Juli 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    19 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Burwell Reed am 02. Feb. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Ben Gujral am 02. Feb. 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 18. Nov. 2014

    • Kapital: USD 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    22 SeitenAA

    Ernennung von Mr Ben Gujral als Direktor am 17. Juni 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Frederic Pascal Maurice Fumey als Geschäftsführer am 11. Juni 2014

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr John Reed als Direktor am 28. März 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Nicolas Robert Maxime Moute als Geschäftsführer am 28. März 2014

    1 SeitenTM01

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    49 SeitenAA

    Ernennung von Frederic Pascal Maurice Fumey als Direktor am 02. Okt. 2013

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Patrick Pierre Chapalain als Geschäftsführer am 26. Mai 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mathieu Jacques Guillemin als Geschäftsführer am 22. Jan. 2013

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung eines Sekretärs

    2 SeitenTM02

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Okt. 2012 bis 31. Dez. 2012

    1 SeitenAA01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 27 Knightsbridge London SW1X 7LY United Kingdom am 15. Okt. 2012

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von IREMIS HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REED, John Burwell
    The Metro Building
    Butterwick
    W6 8DL London
    2nd Floor East
    England
    Geschäftsführer
    The Metro Building
    Butterwick
    W6 8DL London
    2nd Floor East
    England
    EnglandAmerican182558800001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    C/O Hackwood Secretaries Limited
    United Kingdom
    Sekretär
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    C/O Hackwood Secretaries Limited
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer2600095
    147306890001
    CHAPALAIN, Patrick Pierre
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    C/O Hackwood Secretaries Limited
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    C/O Hackwood Secretaries Limited
    United Kingdom
    FranceFrench159852100002
    FUMEY, Frederic Pascal Maurice
    Chemin De Saint Michel
    83440 Montauroux
    71
    France
    Geschäftsführer
    Chemin De Saint Michel
    83440 Montauroux
    71
    France
    United Arab EmiratesFrench180238800001
    GUILLEMIN, Mathieu Jacques
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    C/O Hackwood Secretaries Limited
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    C/O Hackwood Secretaries Limited
    United Kingdom
    FranceFrench159852080001
    GUJRAL, Ben
    The Metro Building
    Butterwick
    W6 8DL London
    2nd Floor East
    England
    Geschäftsführer
    The Metro Building
    Butterwick
    W6 8DL London
    2nd Floor East
    England
    United KingdomBritish117933240001
    MOUTE, Nicolas Robert Maxime
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    C/O Hackwood Secretaries Limited
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    C/O Hackwood Secretaries Limited
    United Kingdom
    FranceFrench159852090001

    Hat IREMIS HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Second ranking mortgage over shares
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 19. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the newco obligors or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its rights title and interest in and to the original shares. Any derivative assets. Shares means the original shares and all other shares in gulmar offshore limited see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • International Shipping Finance 4711 LTD
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Second ranking mortgage over shares
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 19. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the newco obligors or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its rights title and interest in and to the original shares. Any derivative assets. Original shares means 2,100 shares of us$1 each in condor shipco, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • International Shipping Finance 4711 LTD
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Second ranking mortgage over shares
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 19. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the newco obligors or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to the original shares being 2,100 shares of us$1 each in gulmar chartering limited and any derivative assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • International Shipping Finance 4711 LTD
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Second ranking mortgage over shares
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 19. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the newco obligors or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to the original shares being 2,100 shares of us$1 each in falcon shipco and any derivative assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • International Shipping Finance 4711 LTD
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Second ranking mortgage over shares
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 19. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the newco obligors or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to the original shares being 2,100 shares of us$1 each in gulmar interco limited and any derivative assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • International Shipping Finance 4711 LTD
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Second ranking mortgage over shares
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 19. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the newco obligors or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to the original shares being 2,100 shares of us$1 each in eagle shipco and any derivative assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • International Shipping Finance 4711 LTD
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    A reserve cash collateral agreement
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 15. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    An amount of us$3,669,788.49 Deposited with the account holder in the deposit account a/c no 3F 502 549 003 and a/c name gage especes gulamr badaro see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natixis
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage over shares
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 15. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee, the junior lenders or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    2,100 shares of us$1 each in respect of the share capital of gulmar interco limited (the original shares) and the derivative assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natixis
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage over shares
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 15. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee, the junior lenders or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    2,100 shares of us$1 each in respect of the share capital of gulmar chartering limited (the original shares) and the derivative assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natixis
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage over shares
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 15. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee, the junior lenders or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    100 shares of us$1 each in respect of the share capital of gulmar offshore limited (the original shares) and the derivative assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natixis
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage over shares
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 15. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee, the junior lenders or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    2,100 shares of us$1 each in respect of the share capital of eagle shipco limited (the original shares) and the derivative assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natixis
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage over shares
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 15. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee, the junior lenders or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    2,100 shares of us$1 each in respect of the share capital of condor shipco limited (the original shares) and the derivative assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natixis
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage over shares
    Erstellt am 06. Dez. 2011
    Geliefert am 15. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee, the junior lenders or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    2,100 shares of us$1 each in respect of the share capital of falcon shipco limited (the original shares) and the derivative assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natixis
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0