LAVASTORM ANALYTICS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LAVASTORM ANALYTICS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Liquidation |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 07767670 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LAVASTORM ANALYTICS LIMITED?
- Entwicklung von Geschäfts- und Haushaltssoftware (62012) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich LAVASTORM ANALYTICS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane Finchley N12 8LY London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LAVASTORM ANALYTICS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MDS LAVASTORM ANALYTICS LIMITED | 08. Sept. 2011 | 08. Sept. 2011 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LAVASTORM ANALYTICS LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. März 2023 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. März 2024 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für LAVASTORM ANALYTICS LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 08. Sept. 2024 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 22. Sept. 2024 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 08. Sept. 2023 |
Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für LAVASTORM ANALYTICS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor, the Pinnacle 20 Tudor Road Reading Berkshire RG1 1NH England zum Pearl Assurance House 319 Ballards Lane Finchley London N12 8LY am 31. Dez. 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 05. Dez. 2023
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 04. Dez. 2023
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom The Point 410 Birchwood Boulevard Birchwood Warrington WA3 7WD England zum 20 Tudor Road 3rd Floor Reading RG1 1NH geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Sept. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Precisely Software Limited as a person with significant control on 31. Jan. 2023 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patrick Michael Collins als Geschäftsführer am 28. Apr. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2022 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Suite 112 Portal Business Centre Dallam Court Dallam Road Warrington WA2 7LT United Kingdom zum 3rd Floor, the Pinnacle 20 Tudor Road Reading Berkshire RG1 1NH am 09. Dez. 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Cessation of Infogix, Inc. as a person with significant control on 24. Juni 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Cessation of Infogix Parent Corporation as a person with significant control on 31. Dez. 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Cessation of Infogix Holdings, Inc. as a person with significant control on 31. Dez. 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2021 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Notification of Infogix Holdings, Inc. as a person with significant control on 23. März 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Notification of Infogix Parent Corporation as a person with significant control on 23. März 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Notification of Infogix, Inc. as a person with significant control on 23. März 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LAVASTORM ANALYTICS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAJAC, Craig Paul | Sekretär | c/o Precisely Software Incorporated District Avenue, #300 Burlington 1700 Ma 01803 United States | 286674670001 | |||||||
ROGERS, Joseph David | Geschäftsführer | c/o Precisely Software Incorporated District Avenue, #300 Burlington 1700 Ma 01803 United States | United States | American | Chief Executive Officer | 183631940001 | ||||
BRANDT, Lacey P. | Sekretär | Summer Street Boston 321 Massachusetts, 02210 Usa | 182178650001 | |||||||
STEPHENS, Early | Sekretär | Dallam Court Dallam Road WA2 7LT Warrington Suite 112 Portal Business Centre United Kingdom | 244962570001 | |||||||
BISHOF, Mark Christopher | Geschäftsführer | The Cornfields Bishops Cleeve GL52 7YQ Cheltenham 1 Gloucestershire England | United States | American | Director | 151577560001 | ||||
COLLINS, Patrick Michael | Geschäftsführer | c/o Precisely Software Incorporated District Avenue, #300 Burlington 1700 Ma 01803 United States | United States | American | Chief Financial Officer | 286674580001 | ||||
CRABILL, Scott | Geschäftsführer | The Cornfields Bishops Cleeve GL52 7YQ Cheltenham 1 Gloucestershire England | United States | American | Director | 244994550001 | ||||
DAWES, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | Martin Dawes House Europa Boulevard, Westbrook WA5 7BH Warrington C/O Janice Duncan United Kingdom | England | British | Company Director | 142847270001 | ||||
DAWES, Hayley Jane | Geschäftsführer | Martin Dawes House Europa Boulevard, Westbrook WA5 7BH Warrington C/O Janice Duncan United Kingdom | England | British | Company Director | 166870740001 | ||||
DAWES, Martin Richard | Geschäftsführer | Martin Dawes House Europa Boulevard, Westbrook WA5 7BH Warrington C/O Janice Duncan United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 169043540001 | ||||
DAWES, Paul Richard | Geschäftsführer | Martin Dawes House Europa Boulevard, Westbrook WA5 7BH Warrington C/O Janice Duncan United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 128360200002 | ||||
HUEMME, Anne Dudley | Geschäftsführer | 5th Floor Boston 321 Summer Street Ma 02210 Usa | United States | American | Chief Financial Officer | 206087880001 | ||||
KATIYAR, Sameer | Geschäftsführer | The Cornfields Bishops Cleeve GL52 7YQ Cheltenham 1 England And Wales United Kingdom | United States | Indian | Company Director | 295368940001 | ||||
PRESS, Carl Minoo | Geschäftsführer | The Cornfields Bishops Cleeve GL52 7YQ Cheltenham 1 Gloucestershire England | United States | American | Director | 242635800001 | ||||
RHODE, Aj | Geschäftsführer | The Cornfields Bishops Cleeve GL52 7YQ Cheltenham 1 Gloucestershire England | United States | American | Director | 244971260001 | ||||
ROCKWELL, Andrew | Geschäftsführer | Cinnamon Park Fearnhead WA2 0XU Warrington Network House Cheshire United Kingdom | United States | American | Director | 162893230001 | ||||
SHIELDS, Peter Randell | Geschäftsführer | Summer Street 3rd Floor Boston 321 Ma 02210 Usa | United States | Usa | Chief Executive Officer | 205013420001 | ||||
STEPHENS, Early | Geschäftsführer | Dallam Court Dallam Road WA2 7LT Warrington Suite 112 Portal Business Centre United Kingdom | United States | American | Director | 244979300001 | ||||
THOMA, Carl | Geschäftsführer | The Cornfields Bishops Cleeve GL52 7YQ Cheltenham 1 Gloucestershire England | United States | American | Director | 244971130001 | ||||
THOMAS, Dewi Eifion | Geschäftsführer | Cinnamon Park Fearnhead WA2 0XU Warrington Network House Cheshire United Kingdom | Wales | British | Company Director | 58588960001 | ||||
WEISS, David | Geschäftsführer | The Cornfields Bishops Cleeve GL52 7YQ Cheltenham 1 Gloucestershire England | United States | American | Director | 244979180001 | ||||
WILLIAM MCKINZIE, G | Geschäftsführer | The Cornfields Bishops Cleeve GL52 7YQ Cheltenham 1 Gloucestershire England | United States | American | Director | 244981650001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LAVASTORM ANALYTICS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precisely Software Limited | 31. Jan. 2023 | Tudor Road RG1 1NH Reading 20 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Precisely Software Incorporated | 28. Mai 2021 | District Ave, #300 01803 Burlington 1700 Massachusetts United States | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Infogix, Inc. | 23. März 2018 | District Ave, #300 C/O Precisely Software Incorporated 01803 Burlington 1700 Massachusetts United States | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Infogix Parent Corporation | 23. März 2018 | District Ave, #300 C/O Precisely Software Incorporated 01803 Burlington 1700 Massachusetts United States | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Infogix Holdings, Inc. | 23. März 2018 | District Ave #300 C/O Precisely Software Incorporated 01803 Burlington 1700 Massachusetts United States | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
New Lavastorm (2017) Limited | 23. März 2018 | Dallam Court Dallam Road WA2 7LT Warrington Suite 112 Portal Business Centre United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Lavastorm Analytics (Uk) Group Limited | 06. Apr. 2016 | Europa Boulevard Westbrook WA5 7WH Warrington Martin Dawes House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat LAVASTORM ANALYTICS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 10. Aug. 2016 Geliefert am 23. Aug. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The company charged by way of first fixed charge all its real property (although no further details are specified in the charge). For further detail see clauses 3.1(a) and 3.1(b) . the company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge). For further detail see clause 3.1(k). Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 31. März 2016 Geliefert am 12. Apr. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 27. Mai 2015 Geliefert am 03. Juni 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 09. Juli 2014 Geliefert am 17. Juli 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 09. Juli 2014 Geliefert am 14. Juli 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession supplemental to an omnibus guarantee & set-off agreement dated 10 august 2011 | Erstellt am 30. Dez. 2011 Geliefert am 17. Jan. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Each company guarantees the payment of the principal's liabilities in the currency or respective currencies thereof on demand by the bank see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Dez. 2011 Geliefert am 17. Jan. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat LAVASTORM ANALYTICS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0