FAIRWIM PROPERTIES NO.1 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FAIRWIM PROPERTIES NO.1 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 08009199 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FAIRWIM PROPERTIES NO.1 LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich FAIRWIM PROPERTIES NO.1 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Berkeley House 304,Regents Park Road N3 2JX London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FAIRWIM PROPERTIES NO.1 LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für FAIRWIM PROPERTIES NO.1 LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 28. März 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 11. Apr. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 28. März 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für FAIRWIM PROPERTIES NO.1 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Michael David Watson als Direktor am 22. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Notification of Lightyear Estates Holdings Limited as a person with significant control on 12. Aug. 2019 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Jlppt Holdco 5 Limited as a person with significant control on 12. Aug. 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr William Kenneth Procter am 12. Aug. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Charles Mcgill am 12. Aug. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Ernennung von Mr Paul Hallam als Direktor am 12. Aug. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Daniel Lau als Sekretär am 12. Aug. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||
Ernennung von Mr Christopher Charles Mcgill als Direktor am 12. Aug. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr William Kenneth Procter als Direktor am 12. Aug. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 6th Floor Grand Buildings 1-3 Strand London WC2N 5HR England zum Berkeley House 304,Regents Park Road London N3 2JX am 20. Sept. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Charles George William Crowe als Geschäftsführer am 12. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul Richard Dennis-Jones als Geschäftsführer am 12. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 13 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Grand Buildings 1-3 Strand Trafalgar Square London WC2N 5HR zum 6th Floor Grand Buildings 1-3 Strand London WC2N 5HR am 01. Feb. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von FAIRWIM PROPERTIES NO.1 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAU, Daniel | Sekretär | 304,Regents Park Road N3 2JX London Berkeley House England | 262598100001 | |||||||
HALLAM, Paul | Geschäftsführer | 304,Regents Park Road N3 2JX London Berkeley House England | England | British | Chartered Accountant | 260389200001 | ||||
MCGILL, Christopher Charles | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 England | England | British | Managing Director | 164210850001 | ||||
PROCTER, William Kenneth | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 England | England | British | Accountant | 179204780001 | ||||
WATSON, Michael David | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 England | England | British | Chartered Accountant | 63440350001 | ||||
HALLAM, Paul | Sekretär | 302 Regents Park Road Finchley N3 2JX London Molteno House United Kingdom | 169594070001 | |||||||
CROWE, Charles George William | Geschäftsführer | 1-3 Strand WC2N 5HR London 6th Floor Grand Buildings England | England | British | Director | 189410690001 | ||||
DENNIS-JONES, Paul Richard | Geschäftsführer | 1-3 Strand WC2N 5HR London 6th Floor Grand Buildings England | England | British | Director | 189410700001 | ||||
MCGILL, Christopher Charles | Geschäftsführer | Park Lane Mayfair W1K 1RB London 35 United Kingdom | England | British | Director | 158021700001 | ||||
PROCTER, William Kenneth, Mr. | Geschäftsführer | Park Lane Mayfair W1K 1RB London 35 United Kingdom | England | British | Director | 98678880014 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FAIRWIM PROPERTIES NO.1 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightyear Estates Holdings Limited | 12. Aug. 2019 | 304,Regents Park Road N3 2JX London Berkeley House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Jlppt Holdco 5 Limited | 06. Apr. 2016 | 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat FAIRWIM PROPERTIES NO.1 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 22. Juli 2014 Geliefert am 25. Juli 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 14. Nov. 2013 Geliefert am 29. Nov. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung F/H 39,41,43,45,47 and 49 church street, uttoxeter and land lying to the north west of church street in the district of staffordshire known as the stables uttoxeter - SF579990. F/h and and buildings on the east side of ashley down road in the city of bristol known as flats 1-9, flats 15-20 (inclusive), flats 37-42 (inclusive), flats 64-69 (inclusive), flats 73-78 (inclusive) and flats 82-87 (inculsive) dirac road ashley down bristol avon (for further details of property charged please see form MR01) see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 14. Nov. 2013 Geliefert am 23. Nov. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Mai 2012 Geliefert am 13. Juni 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H land k/a land and buildings on the north east side of crescent road in the district of bolton k/a flats 1 - 12 and flats 14-20 (inclusive) and flats 21 - 39 (odd) ramswell close, for further details of property charged please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Mai 2012 Geliefert am 13. Juni 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land and buildings in the development k/a victoria wharf ferry road grange town cardiff formerly comprised within f/h t/n's CYM286944, CYM233328 and CYM194013 and land and buildings in the development k/a buckland house watercolour redhill formerly comprised in the f/h t/n's SY771126 and SY755743 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0