PORT MERCANTILE LTD
Überblick
| Unternehmensname | PORT MERCANTILE LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 09845417 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PORT MERCANTILE LTD?
- Sonstige Nebentätigkeiten im Finanz- und Versicherungswesen n.n.a. (66190) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich PORT MERCANTILE LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 555-557 Cranbrook Road Gants Hill IG2 6HE Ilford England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PORT MERCANTILE LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PORT MERCANTILE LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 098454170001 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juli 2021 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2020 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2019 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juli 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juli 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2018 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Efraim Zazo als Direktor am 08. Juli 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juli 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2017 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dominic Mirza als Geschäftsführer am 16. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juli 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Efraim Zazo as a person with significant control on 16. Aug. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Cessation of Ghulam Asghar Alahi as a person with significant control on 16. Aug. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 098454170001, erstellt am 30. Aug. 2016 | 22 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Ghulam Asghar Alahi als Direktor am 30. Juni 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Geerish Gukhool als Geschäftsführer am 28. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Geerish Gukhool als Sekretär am 28. Juni 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Dominic Mirza als Direktor am 28. Juni 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PORT MERCANTILE LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAHI, Ghulam Asghar | Geschäftsführer | Gants Hill IG2 6HE Ilford 555-557 Cranbrook Road England | England | British | 79440030004 | |||||
| ZAZO, Efraim | Geschäftsführer | Cranbrook Road IG2 6HE Ilford 555-557 London United Kingdom | United Kingdom | Israeli | 254855090001 | |||||
| GUKHOOL, Geerish | Sekretär | CR0 7QT Croydon 6 Pippin Close England | 202177080001 | |||||||
| GUKHOOL, Geerish | Geschäftsführer | CR0 7QT Croydon 6 Pippin Close England | United Kingdom | British | 185714100001 | |||||
| MIRZA, Dominic | Geschäftsführer | Gants Hill IG2 6HE Ilford 555-557 Cranbrook Road England | England | British | 209489340001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PORT MERCANTILE LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Efraim Zazo | 16. Aug. 2016 | Gants Hill IG2 6HE Ilford 555-557 Cranbrook Road England | Nein |
Nationalität: Israeli Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Ghulam Asghar Alahi | 15. Aug. 2016 | Gants Hill IG2 6HE Ilford 555-557 Cranbrook Road England | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat PORT MERCANTILE LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 30. Aug. 2016 Geliefert am 12. Sept. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 1. by way of legal mortgage:. 1.1 all estates or interests in the freehold and leasehold property described in schedule 1 together with all present and future buildings, fixtures (including trade and tenant’s fixtures), plant and machinery which are at any time on such property;. 2. by way of fixed charge:. 2.1 all estates or interests in any freehold or leasehold property belonging to the company now or at any time after the date of this debenture (other than any property charged in terms of clause 2.1.1 in the debenture) together with all buildings, fixtures (including trade and tenant’s fixtures), plant and machinery which are at any time on the property;. 2.1.1 all present and future interests of the company in or over land or the proceeds of sale of it and all present and future licences of the company to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land to which it is or may become party or otherwise entitled and all fixtures (including trade and tenant’s fixtures) which are at any time on the property charged under the debenture;. 2.1.2 all present and future plant and machinery not otherwise charged under clause 2 of the debenture and all other present and future chattels of the company (excluding any of the same for the time being forming part of the company’s stock in trade or work in progress);. 2.1.3 all patents, patent applications, trade marks, trade mark applications, trading names, brand names, service marks, copyrights, rights in the nature of copyright, moral rights, inventions, design rights, registered designs, all trade secrets and know-how, computer rights, programmes, systems, tapes, disks, software, all applications for registration of any of them and other intellectual property rights held or to be held by the company or in which it may have an interest and the benefit of all present and future agreements relating to the use of or licensing or exploitation of any such rights (owned by the company or others) and all present and future fees, royalties or similar income derived from or incidental to any of the foregoing in any part of the world;. Belastungsgrundlage als Bare Trust: Ja Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0