NATWEST MARKETS N.V.

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Ausländisches Unternehmen
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNATWEST MARKETS N.V.
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformAusländische Gesellschaft
    Unternehmensnummer FC006193
    Externe Registrierungsnummer2587
    GerichtsbarkeitVereinigtes Königreich
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Wo befindet sich NATWEST MARKETS N.V.?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Branch Registration
    Refer To Parent Registry
    Netherlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NATWEST MARKETS N.V.?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.09. Feb. 201009. Feb. 2010
    ABN AMRO BANK N.V.08. Feb. 196808. Feb. 1968

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NATWEST MARKETS N.V.?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2017
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    NATWEST MARKETS N.V. ist ein ausländisches Unternehmen

    Buchführungspflicht für ausländische Unternehmen
    Art des ausländischen JahresabschlussesEs gelten die Rechnungslegungsvorschriften des Ursprungslandes
    Bedingungen für die Veröffentlichung des JahresabschlussesVeröffentlichungsdatum der Rechnungsabschlüsse muss vom Unternehmen nicht geliefert werden
    RechtsformPublic Comp. Limited By Shares
    Ist ein Kredit- oder FinanzinstitutNein
    UrsprungsregisterlandNETHERLANDS
    RegistrierungsortChamber Of Commerce Amsterdam
    Unternehmensnummer2587

    Welche sind die letzten Einreichungen für NATWEST MARKETS N.V.?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Beendigung der Bestellung von Gino Gianni Gorter als Sekretär am 31. Okt. 2025

    2 SeitenOSTM02

    Ernennung von Julio Alvaro Esteban zum Direktor am 23. Sept. 2025

    3 SeitenOSAP01

    Ernennung von Britta Achmann zum Direktor am 01. Dez. 2024

    3 SeitenOSAP01

    Ernennung von Sylvie Catherine Marcelle Billion zum Direktor am 15. Okt. 2025

    3 SeitenOSAP01

    Beendigung der Bestellung von Franck Emmanuel Dangeard als Geschäftsführer am 23. Apr. 2025

    2 SeitenOSTM01

    Ernennung von Franck Emmanuel Dangeard zum Direktor am 18. Apr. 2024

    3 SeitenOSAP01

    Beendigung der Bestellung von Reina-Marije Elkenbracht als Geschäftsführer am 31. März 2024

    2 SeitenOSTM01

    Ernennung von Michael Van Wieringen zum Direktor am 01. Mai 2024

    3 SeitenOSAP01

    Beendigung der Bestellung von Angelique Maria Oplaat Slag als Geschäftsführer am 11. Okt. 2023

    2 SeitenOSTM01

    Ernennung von Maarten Jan Hendrik Klessens zum Direktor am 02. Sept. 2015

    3 SeitenOSAP01

    Ernennung von Vincent Goedegebuure zum Direktor am 09. Mai 2022

    3 SeitenOSAP01

    Ernennung von Antje Elisabeth Van Der Pauw zum Direktor am 03. März 2019

    3 SeitenOSAP01

    Beendigung der Bestellung von Harm Dirk Lodewijk Bots als Geschäftsführer am 23. Sept. 2021

    2 SeitenOSTM01

    Ernennung von Chairman of the Supervisory Board Robert Begbie zum Direktor am 01. Apr. 2020

    3 SeitenOSAP01

    Ernennung von Angelique Maria Oplaat Slag zum Direktor am 18. März 2019

    4 SeitenOSAP01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    26. Juni 2019Clarification THIS DOCUMENT IS A SECOND FILING OF OSAP01 REGISTERED ON 25/05/2019

    Ernennung von Ms Reina-Marije Elkenbracht zum Direktor am 15. Feb. 2019

    3 SeitenOSAP01

    Ernennung von Ms Angelique-Maria Slag Elkenbracht zum Direktor am 18. März 2019

    4 SeitenOSAP01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    26. Juni 2019Clarification A SECOND FILED OSAP01 WAS REGISTERED ON 26/06/2019

    Ernennung von Harm Dirk Lodewijk Bots zum Direktor am 01. Nov. 2017

    3 SeitenOSAP01

    Beendigung der Bestellung von Michael Peter Geslak als Geschäftsführer am 30. Sept. 2016

    2 SeitenOSTM01

    Beendigung der Bestellung von Jeroen Joseph Marie Kremers als Geschäftsführer am 01. Apr. 2014

    2 SeitenOSTM01

    Beendigung der Bestellung von Johannes Anton De Ruiter als Geschäftsführer am 31. Juli 2015

    2 SeitenOSTM01

    Änderungen für eine britische Niederlassung - BR001029 Name Change Natwest market N.v (london branch),30. Apr. 2018

    3 SeitenOSCH01

    Änderung der Satzungsdokumente am 30. Apr. 2018

    20 SeitenOSCC01

    Ernennung von Gino Gianni Gorter zum Sekretär am 01. Jan. 2014

    3 SeitenOSAP03

    Änderungen für eine britische Niederlassung - BR001029 Name Change The royal bank of scotland N.V.,30. Apr. 2018

    3 SeitenOSCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von NATWEST MARKETS N.V.?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ACHMANN, Britta
    94 Claude Debussylaan
    Amsterdam
    1082md
    Netherlands
    Geschäftsführer
    94 Claude Debussylaan
    Amsterdam
    1082md
    Netherlands
    NetherlandsGerman342441440001
    BEGBIE, Robert
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    United Kingdom
    ScotlandBritish269440490001
    BILLION, Sylvie Catherine Marcelle
    94 Claude Debussylaan
    Amsterdam, 1082md
    Netherlands
    Geschäftsführer
    94 Claude Debussylaan
    Amsterdam, 1082md
    Netherlands
    FranceFrench342441310001
    ESTEBAN, Julio Alvaro
    94 Claude Debussylaan
    Amsterdam
    1082md
    Netherlands
    Geschäftsführer
    94 Claude Debussylaan
    Amsterdam
    1082md
    Netherlands
    SpainSpanish342441740001
    GOEDEGEBUURE, Vincent
    Claude Debussylaan
    1082 Md
    Amsterdam
    94
    1082 Md
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Claude Debussylaan
    1082 Md
    Amsterdam
    94
    1082 Md
    Netherlands
    NetherlandsDutch315445210001
    KLESSENS, Maarten Jan Hendrik
    Claude Debussylaan
    1082 Md
    Amsterdam
    94
    1082 Md
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Claude Debussylaan
    1082 Md
    Amsterdam
    94
    1082 Md
    Netherlands
    NetherlandsDutch315445370001
    VAN DER PAUW, Antje Elisabeth
    Claude Debussylaan
    1082 Md
    Amsterdam
    94
    1082 Md
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Claude Debussylaan
    1082 Md
    Amsterdam
    94
    1082 Md
    Netherlands
    NetherlandsDutch315445100001
    VAN WIERINGEN, Michael
    Claude Debussaylaan
    1082 Md
    Amsterdam
    94
    1082 Md
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Claude Debussaylaan
    1082 Md
    Amsterdam
    94
    1082 Md
    Netherlands
    NetherlandsDutch324689590001
    VISSCHER, Cornelis
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    United Kingdom
    NetherlandsDutch181692060001
    GORTER, Gino Gianni
    Claude Debussylaan
    Amsterdam
    94
    1082md
    Netherlands
    Sekretär
    Claude Debussylaan
    Amsterdam
    94
    1082md
    Netherlands
    248639540001
    BOTS, Harm Dirk Lodewijk
    Claude Debussylaan, 7th Floor
    Amsterdam
    94
    1082md
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Claude Debussylaan, 7th Floor
    Amsterdam
    94
    1082md
    Netherlands
    NetherlandsDutch250010000001
    BOUMEESTER, Huibert Gerard
    Wilton Crescent
    SW1X 8RX London
    45
    Geschäftsführer
    Wilton Crescent
    SW1X 8RX London
    45
    Dutch95743530004
    COLE, David Alan
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    Geschäftsführer
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    Dutch137896390001
    COLLEE, Cenraad Hendrik Adolf
    Burg. Den Texlaan 45
    2111 Cc Aerdenhout
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    Burg. Den Texlaan 45
    2111 Cc Aerdenhout
    The Netherlands
    British82463950001
    CROWE, Brian John
    Gustav Mahlerlaan 10
    Amsetrdam
    1082 Pp
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    Gustav Mahlerlaan 10
    Amsetrdam
    1082 Pp
    The Netherlands
    British126196690001
    DANGEARD, Franck Emmanuel
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    United Kingdom
    EnglandFrench324880440001
    DE BIEVRE, Louis Desire Jean Isidore Charles
    Bachlaan 15
    Hilversun
    1217 Bt
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Bachlaan 15
    Hilversun
    1217 Bt
    Netherlands
    Dutch47230430001
    DE BOECK, Karel August Maria
    Groenestaakstraat 57
    FOREIGN Mariakerke-Gent
    B-9030
    Belgium
    Geschäftsführer
    Groenestaakstraat 57
    FOREIGN Mariakerke-Gent
    B-9030
    Belgium
    Belgian107762690001
    DE JONG, Jan Maarten
    Munterslaantje 2
    Aerdenhout 2111
    Holland
    Geschäftsführer
    Munterslaantje 2
    Aerdenhout 2111
    Holland
    Dutch72087310001
    DE JONG, Michiel Gerrit Jan
    2244AB Wassenaar
    Buurtweg 87
    Geschäftsführer
    2244AB Wassenaar
    Buurtweg 87
    Dutch130497460001
    DE RUITER, Johannes Anton
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    Geschäftsführer
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    United KingdomDutch151461860001
    DE SWAAN, Tommy
    Messchaertstraat 18
    FOREIGN 1077 Ws Amsterdam
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    Messchaertstraat 18
    FOREIGN 1077 Ws Amsterdam
    The Netherlands
    Dutch61969380001
    DOR, Paul
    Fond Agny 33
    Lasne
    1380
    Belgium
    Geschäftsführer
    Fond Agny 33
    Lasne
    1380
    Belgium
    Belgian95741790001
    DRABBE, Michael Aohn
    Prinsenvinkenpark 15
    S-Sgravenhage
    2585 Hk
    Usa
    Geschäftsführer
    Prinsenvinkenpark 15
    S-Sgravenhage
    2585 Hk
    Usa
    Dutch47230420001
    ELKENBRACHT, Reina-Marije
    Claude Debussylaan 94
    The Netherlands
    The Rock
    1082md
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Claude Debussylaan 94
    The Netherlands
    The Rock
    1082md
    Netherlands
    NetherlandsDutch258877650001
    ELORZA TRUEBA, Marta Maria
    C/Hermosilla 49 2e Lzq
    FOREIGN Madrid
    28001
    Spain
    Geschäftsführer
    C/Hermosilla 49 2e Lzq
    FOREIGN Madrid
    28001
    Spain
    Spanish126195080001
    FISHER, Mark Andrew
    36 St Andrew Square
    EH2 2YB Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    36 St Andrew Square
    EH2 2YB Edinburgh
    Midlothian
    British80699410002
    GESLAK, Michael Peter
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    Geschäftsführer
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    EnglandAmerican120318140002
    GROENINK, Rijkman Willem Johan
    Kelkweg 2
    Blarucim
    1261 Gv
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Kelkweg 2
    Blarucim
    1261 Gv
    Netherlands
    Dutch47230410001
    HEMSLEY, Richard Andrew
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    United Kingdom
    United KingdomBritish183253160001
    HOFSTE, Petronella Hermina Maria
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    Geschäftsführer
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    United KingdomDutch151461610001
    HOURICAN, John Patrick
    Gustav Mahlerlaan 10
    FOREIGN Amsterdam
    1082 Pp
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    Gustav Mahlerlaan 10
    FOREIGN Amsterdam
    1082 Pp
    The Netherlands
    Irish126196790001
    JISKOOT, Wilco Gustaaf
    Jordaan 15
    1251PB 1251 Pblaren
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Jordaan 15
    1251PB 1251 Pblaren
    Netherlands
    Dutch33931260001
    KALFF, Peter Jan
    Groot Hertoginnelaan 32
    Bussum
    1405 Ee
    Usa
    Geschäftsführer
    Groot Hertoginnelaan 32
    Bussum
    1405 Ee
    Usa
    Dutch47230390001
    KEYS, Theodore Antonius Joseph
    Keizersgracht 644
    Amsterdam
    1017 Es
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Keizersgracht 644
    Amsterdam
    1017 Es
    Netherlands
    Dutch47230380001

    Hat NATWEST MARKETS N.V. Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Pledge agreement
    Erstellt am 08. Sept. 2011
    Geliefert am 14. Sept. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the collateral see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • European Central Counterparty Limited
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental security deed
    Erstellt am 08. Sept. 2011
    Geliefert am 14. Sept. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interoperating margin fund contributions see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • European Central Counterparty Limited
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Prime brokerage agreement
    Erstellt am 02. Aug. 2011
    Geliefert am 11. Aug. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge and first floating charge the charged assets being equity securities and PLC paper held in the pb account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    A sub-participation agreement
    Erstellt am 19. Juli 2011
    Geliefert am 22. Juli 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    An assignment of the assigned claims in the proportion of the bank's proportion in rbs' portion of the loans see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dekabank Deutsche Girozentrale
    Transaktionen
    • 22. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 02. Juli 2009
    Geliefert am 07. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge all securities deposits and any other assets now or at any time hereafter belonging to the chargor see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New Your Mellon
    Transaktionen
    • 07. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security deed
    Erstellt am 15. Aug. 2008
    Geliefert am 21. Aug. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights in all cash margin amounts and all cash contributions, all certificated securities, all uncertificated securities, floating charge all securities and other property deliverable, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • European Central Counterparty Limited
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Pledge agreement
    Erstellt am 15. Aug. 2008
    Geliefert am 21. Aug. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right in the euroclear securities being all securities deposited with or transferred by the company to a pledgee’s representative in euroclear for the credit of a euroclear pledged account, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • European Central Counterparty Limited
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security assignment
    Erstellt am 10. Apr. 2008
    Geliefert am 29. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its rights, title and interest now and in the future in the assigned agreements, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Secured Party)
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over cash accounts and rights
    Erstellt am 10. Apr. 2008
    Geliefert am 29. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge and first fixed floating charge all of its right title and interest in and to each account and each deposit, all of the proceeds of the realisation of the pledged assets, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Secured Party)
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental to collateral agreement governing secured borrowings by groups of participants in the euroclear system
    Erstellt am 30. Juni 2006
    Geliefert am 17. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and its related parti(es) (the borrower) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Euroclear Banks S.A./N.V.
    Transaktionen
    • 17. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Euroclear pledge agreement
    Erstellt am 09. Dez. 2003
    Geliefert am 19. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies, limited to £500,000,000, due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The euroclear securities and all rights title and interest to the euroclear securities.
    Berechtigte Personen
    • Glaxo Group Limited
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of subordination
    Erstellt am 25. Juni 2003
    Geliefert am 16. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the english borrowers or alba security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assign all or any part of eahl's assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V.
    Transaktionen
    • 16. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Originator pledge agreement created outside the united kingdom and comprising property situated there
    Erstellt am 29. Sept. 2000
    Geliefert am 17. Okt. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Under the master security agreement the company irrevocably and unconditionally undertakes to pay to the security agent amounts equal to the and in the currency of the originator principal obligations
    Kurze Angaben
    1. under the originator pledge agreement the company has granted (I) a disclosed first priority right of pledge over the pledged claims and (ii) in advance a disclosed first priority right of pledge insofar as the same cannot be fully granted as of the date of the pledge (20 september 2000). 2. the originator pledge agreement contains a negative pledge in respect of the pledged claims. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Stichting Amstel Consumer Loan Security Agent 2000-1 (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment an pledge credited outside the united kingdom and comprising property situated there
    Erstellt am 29. Sept. 2000
    Geliefert am 17. Okt. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Subject to the master agreement the deed of assignment and pledge secures the obligation of the company to (a) assign to the receivables purchaser eligible accounts and eligible receivables having an aggregate value equal to approximately 430M euro on the closing date and thereafter equal to the aggregate of the issuer interest and the originator interest in the portfolio from time to time and (b) pay to the security agent amounts equal to and in the currency of the originator principal obligations
    Kurze Angaben
    The company has (a) assigned (cedeert hierbij) to amstel consumer loan purchase company 2000-1 B.V. the benefit of all existing receivables and future receivables under the initial accounts in accordance with articles 3:94 of the netherlands civil code;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Stichting Amstel Consumer Loan Security Agent 2000-1 (As Security Agent) Amstel Consumer Loan Purchase Company 2000-1 B.V.(as Receivables Purchaser)
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Collateral agreement between the company and tradego S.A./N.V.
    Erstellt am 01. Aug. 2000
    Geliefert am 08. Aug. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The "margin obligations" which means all of the company's obligations and liabilities to the chargee under the operating procedures (including the supplement)
    Kurze Angaben
    The securities collateral, the cash collateral and other collateral whether now existing or hereafter arising or acquired and all of the company's right title and interest in and to the securities collateral, the cash collateral and other collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tradego S.A./N.V.
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Tradego participation agreement between the company and tradego S.A./N.V.
    Erstellt am 01. Aug. 2000
    Geliefert am 08. Aug. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Any and all obligations and liabilities of the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All assets and property of the company held by or on behalf of the chargee including all permitted margin securities (other than acceptable cash) other collateral and other assets or property held by the corporation.
    Berechtigte Personen
    • Tradego S.A./N.V.
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of assignment and pledge
    Erstellt am 16. Dez. 1999
    Geliefert am 06. Jan. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due from the company to the chargee under or pursuant to any relevant document (including the originator parallel debt), whether due and payable or not and whether contingent or not, as such obligations may be extended, prolonged, amended, renewed or novated from time to time
    Kurze Angaben
    The company has (a) assigned (cedeert hierbij) to amstel consumer loan purchase company 1999-1 B.V. the benefit of all existing receivables and future receivables under the initial accounts in accordance with articuls 3:94 of the netherlands civil code;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Amstel Consumer Loan Purchase Company 1999-1 B.V. (As the "Receivables Purchaser")
    • Stichting Amstel Consumer Loan Security Agent 1999-1 (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Originator pledge agreement
    Erstellt am 15. Dez. 1999
    Geliefert am 06. Jan. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the receivables sale agreement and any other relevant document (other than the originator parallel debt), as such obligations may be extended, prolonged, amended, renewed or novated from time to time
    Kurze Angaben
    1. under the originator pledge agreement the company has granted (I) a discolsed first priority right of pledge over the pledged claims and (ii) in advance a discolsed first priority right of pledge insofar as the same cannot be full granted as of the date of the pledge (15 december 1999). 2. the originator pledge agreement contains a negative pledge in respect of the pledged claims.
    Berechtigte Personen
    • Stichting Amstel Consumer Loan Secruity Agent 1999-1 (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0