IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED

IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Ausländisches Unternehmen
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameIRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformAusländische Gesellschaft
    Unternehmensnummer FC016044
    GerichtsbarkeitVereinigtes Königreich
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Wo befindet sich IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Branch Registration
    Refer To Parent Registry
    Ireland
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED29. Apr. 200929. Apr. 2009
    ANGLO IRISH BANK CORPORATION PLC01. Mai 199101. Mai 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Sept. 2012
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED ist ein ausländisches Unternehmen

    Buchführungspflicht für ausländische Unternehmen
    Art des ausländischen JahresabschlussesEs gelten die Rechnungslegungsvorschriften des Ursprungslandes
    Bedingungen für die Veröffentlichung des JahresabschlussesVeröffentlichungsdatum der Rechnungsabschlüsse vom Unternehmen geliefert
    Beginn des GeschäftsjahresTag: 1 Monat: 10
    Ende des GeschäftsjahresTag: 30 Monat: 9
    Monat: 9
    RechtsformRe-Registration As A Private Company Following Nationalisation
    Ist ein Kredit- oder FinanzinstitutNein
    UrsprungsregisterlandIRELAND
    RegistrierungsortCompanies Reg. Office Dublin
    Unternehmensnummer22045

    Welche sind die letzten Einreichungen für IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Änderungen für eine britische Niederlassung - BR000969 Address Change 10 old jewry, london, , EC2R 8DN,30. Juni 2014

    3 SeitenOSCH01

    Ernennung eines Liquidators einer ausländischen Gesellschaft

    3 SeitenOSLQ01

    Liquidation einer ausländischen Gesellschaft

    3 SeitenOSLQ03

    Beendigung der Bestellung von Frank Daly als Geschäftsführer

    2 SeitenOSTM01

    Ernennung eines Direktors

    2 SeitenOSAP01

    Beendigung der Bestellung von Donal O'connor als Geschäftsführer

    2 SeitenOSTM01

    Der Standort des Pfandrechtsregisters wurde geändert

    1 SeitenOSAD02

    Ernennung eines Direktors

    3 SeitenOSAP01

    Ernennung eines Direktors

    3 SeitenOSAP01

    Ernennung eines Direktors

    3 SeitenOSAP01

    Beendigung der Bestellung von Maxwell Barrett als Sekretär

    2 SeitenOSTM02

    Änderung der Details des Direktors für Arthur Michael Robert Aynsley am 01. Nov. 2011

    3 SeitenOSCH03

    Ernennung von Philip Brady zum Sekretär

    4 SeitenOSAP03

    Ernennung eines Direktors

    3 SeitenOSAP01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    181 SeitenAA

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    183 SeitenAA

    Änderung der Satzungsdokumente am 14. Okt. 2011

    36 SeitenOSCC01

    Änderung des eingetragenen Namens einer ausländischen Gesellschaft am 19. Okt. 2011 von {change_name}

    4 SeitenOSNM01

    Verschiedenes

    Notification of overseas company closure due to registration in multiple jurisdictions
    1 SeitenMISC

    Verschiedenes

    Multiple registrations- confirmation of the company in respect of which it intends to make future filings
    1 SeitenMISC

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Harwerth als Geschäftsführer

    4 SeitenOSTM01

    Übergangsrückblick für BR013942 - Person, die zur Vertretung befugt ist, Paul Gareth Kennedy Cuilin Allies River Road Rathmichael Dublin Ireland

    SeitenOSTN01-PAR

    Übergangsrückblick für BR013942 - Änderungen an der Niederlassung im Vereinigten Königreich, Address Change 14/18 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7BA

    SeitenOSTN01-CHNG

    Übergangsrückblick für BR013942 - Änderungen an der Niederlassung im Vereinigten Königreich, Business Change Null

    SeitenOSTN01-CHNG

    Übergangsrückblick für BR013942 - Person, die zur Vertretung befugt ist, Alan Martin Dukes C/O Anglo Irish Bank Corporation Limited Connaught House Dublin 4 Ireland

    SeitenOSTN01-PAR

    Wer sind die Geschäftsführer von IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRADY, Philip
    Stephen Court
    18-21 St Stephens Greend
    Dublin 2
    C/O Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Ireland
    Sekretär
    Stephen Court
    18-21 St Stephens Greend
    Dublin 2
    C/O Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Ireland
    170774300001
    AYNSLEY, Arthur Michael Royal
    Malborough Road
    Glengeary
    Limasol
    Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Malborough Road
    Glengeary
    Limasol
    Dublin
    Ireland
    IrelandAustralian159026000002
    CAWLEY, Noel
    Eadestown
    Naas
    Newpark Lodge Stud
    Kildare
    Ireland
    Geschäftsführer
    Eadestown
    Naas
    Newpark Lodge Stud
    Kildare
    Ireland
    IrelandIrish159026270001
    DALY, Frank Maurice
    Rathdown Park
    Terenure
    85
    Dublin 6w
    Ireland
    Geschäftsführer
    Rathdown Park
    Terenure
    85
    Dublin 6w
    Ireland
    IrelandIrish159026180001
    DUKES, Alan Martin
    Tully West
    Kildare
    Tully West
    Ireland
    Geschäftsführer
    Tully West
    Kildare
    Tully West
    Ireland
    IrelandIrish159023840001
    EAMES, Aidan
    Drumnigh
    Portmarnock
    Drumnigh House
    Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Drumnigh
    Portmarnock
    Drumnigh House
    Dublin
    Ireland
    IrelandIrish159026460001
    ELLINGHAM, Oliver Bernard
    c/o Irish Bank Resolution Corporation Limited
    18-21 St Stephen's Green
    Dublin 2
    Stephen Court
    Ireland
    Geschäftsführer
    c/o Irish Bank Resolution Corporation Limited
    18-21 St Stephen's Green
    Dublin 2
    Stephen Court
    Ireland
    United KingdomBritish177523800001
    HORAN, Maurice Benedict
    c/o Irish Bank Resolution Corporation Limited
    18-21 St Stephen's Green
    Dublin 2
    Stephen Court
    Ireland
    Geschäftsführer
    c/o Irish Bank Resolution Corporation Limited
    18-21 St Stephen's Green
    Dublin 2
    Stephen Court
    Ireland
    IrelandIrish208836870001
    KEANE, Maurice Augustine
    Manor Green
    Rathfarnham
    6
    Dublin 16
    Ireland
    Geschäftsführer
    Manor Green
    Rathfarnham
    6
    Dublin 16
    Ireland
    IrelandBritish54089110001
    KENNEDY, Paul Gareth
    Allies River Road
    Old Conna
    Rathmichael
    Cuilin
    Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Allies River Road
    Old Conna
    Rathmichael
    Cuilin
    Dublin
    Ireland
    IrelandIrish159026370001
    MCGREAL, Roger
    Stephen Court
    18-21 St Stephens Greend
    Dublin 2
    C/O Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Ireland
    Geschäftsführer
    Stephen Court
    18-21 St Stephens Greend
    Dublin 2
    C/O Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Ireland
    IrelandIrish66616180001
    RIDGWAY, Alan
    c/o Irish Bank Resolution Corporation Limited
    18-21 St Stephen's Green
    Dublin 2
    Stephen Court
    Ireland
    Geschäftsführer
    c/o Irish Bank Resolution Corporation Limited
    18-21 St Stephen's Green
    Dublin 2
    Stephen Court
    Ireland
    LuxembourgIrish172998940001
    BARRETT, Maxwell Jude
    Roebuck Road
    Clonskeagh
    51 The Palms
    Dublin 14
    Ireland
    Sekretär
    Roebuck Road
    Clonskeagh
    51 The Palms
    Dublin 14
    Ireland
    British159026540001
    DALY, Bernard
    Collins Avenue West
    Dublin
    253
    9
    Ireland
    Sekretär
    Collins Avenue West
    Dublin
    253
    9
    Ireland
    British159026640001
    MERCER, Natasha Caulfield
    Belmont Avenue
    Donnybrook
    44
    Dublin 4
    Ireland
    Sekretär
    Belmont Avenue
    Donnybrook
    44
    Dublin 4
    Ireland
    British159026840001
    MURPHY, Ronan
    43 Clonkeen Road
    Blackrock
    IRISH Co Dublin
    Ireland
    Sekretär
    43 Clonkeen Road
    Blackrock
    IRISH Co Dublin
    Ireland
    British19817800001
    BARRETT, William Richard
    4 Homelee
    Serpentine Avenue
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Geschäftsführer
    4 Homelee
    Serpentine Avenue
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Irish47328110001
    BRADSHAW, Lar
    Church Road
    Killiney
    Airlie
    Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Church Road
    Killiney
    Airlie
    Dublin
    Ireland
    IrelandIrish159018640001
    BROWNE, Thomas
    Brighton Road
    Foxrock
    Ferney Hill
    Dublin 18
    Ireland
    Geschäftsführer
    Brighton Road
    Foxrock
    Ferney Hill
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish215937180001
    COLEBY, Anthony Laurie
    Horse Fair
    OX16 0AH Banbury
    Country Chambers
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Horse Fair
    OX16 0AH Banbury
    Country Chambers
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish144752200001
    CURRAN, Maurice Robert
    Woodsise Drive
    Castle Park
    Rathfarnham
    14
    Dublin 14
    Ireland
    Geschäftsführer
    Woodsise Drive
    Castle Park
    Rathfarnham
    14
    Dublin 14
    Ireland
    IrelandIrish159001960001
    DALY, Frank Maurice
    Rathdown Park
    Terenure
    85
    Dublin 6w
    Ireland
    Geschäftsführer
    Rathdown Park
    Terenure
    85
    Dublin 6w
    Ireland
    IrelandIrish159026180001
    DRUMM, David Kenneth
    Abington
    Malahide
    20
    Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Abington
    Malahide
    20
    Dublin
    Ireland
    IrelandIrish159018230001
    DRURY, Fintan Colm
    Russian Village
    Kilquade
    Glenaphouca
    Wicklow
    Ireland
    Geschäftsführer
    Russian Village
    Kilquade
    Glenaphouca
    Wicklow
    Ireland
    IrelandIrish171446720001
    FITZPATRICK, Sean Patrick
    Camaderry Whitshed Road
    IRISH Greystones
    Co Wicklow
    Ireland
    Geschäftsführer
    Camaderry Whitshed Road
    IRISH Greystones
    Co Wicklow
    Ireland
    IrelandIrish2885780001
    HARWERTH, Elizabeth Noel
    c/o Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Burlington Road
    Dublin 4
    Connaught House
    Ireland
    Geschäftsführer
    c/o Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Burlington Road
    Dublin 4
    Connaught House
    Ireland
    Irish161335320001
    HERATY, Anne
    Highfield House
    Rathgar
    2
    Dublin 6
    Ireland
    Geschäftsführer
    Highfield House
    Rathgar
    2
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish159019080001
    JACOB, Michael Desmond
    Greyfield
    Newtownpark Avenue
    IRISH Blackrock
    Co. Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Greyfield
    Newtownpark Avenue
    IRISH Blackrock
    Co. Dublin
    Ireland
    Irish47328080001
    JAMAL, Patrica
    St. Margaret's Close
    Putney
    SW15 6HL London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    St. Margaret's Close
    Putney
    SW15 6HL London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish159015880001
    KILLEN, Peter Richard
    3 Killeen Terrace
    IRISH Malahide
    Co. Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    3 Killeen Terrace
    IRISH Malahide
    Co. Dublin
    Ireland
    Irish47328090001
    MCATEER, William Anthony
    7 Highfield Court
    IRISH Marley Grange
    Dublin 16
    Ireland
    Geschäftsführer
    7 Highfield Court
    IRISH Marley Grange
    Dublin 16
    Ireland
    Irish47328070001
    MCCANN, William Mary
    Kind Edward Road
    Bray
    Kylemore
    Wicklow
    Ireland
    Geschäftsführer
    Kind Edward Road
    Bray
    Kylemore
    Wicklow
    Ireland
    Irish47414720002
    MCGANN, Gary
    Stonehouse
    Donnybrook
    Cherryfield
    Dublin 4
    Ireland
    Geschäftsführer
    Stonehouse
    Donnybrook
    Cherryfield
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish41200650001
    MURPHY, Augustine Gerard
    Meevagh
    Asgard Road
    IRISH Howth
    Co Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Meevagh
    Asgard Road
    IRISH Howth
    Co Dublin
    Ireland
    Irish19817830001
    MURRAY, Peter Cyril
    Ash
    Pembroke Gardens
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Geschäftsführer
    Ash
    Pembroke Gardens
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Irish47328130002

    Hat IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 23. Dez. 2008
    Geliefert am 03. Jan. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon account number: 13543420 sort code: 20-77-67 account name: bb re anglo irish bank corporation PLC.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Subcharge
    Erstellt am 22. Apr. 1999
    Geliefert am 27. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any capacity whatsoever of the company to the chargee (the "participant") under any transaction document (as defined)
    Kurze Angaben
    The debenture dated 31ST december creating a charge by way of legal submortgage over albion house commercial way woking t/n's SY324753 and SY637181,122 thorpe road norwich t/n NK188201,norfolk house queensway birmingham t/n WK118424 and norwich union house,plymouth by way of first fixed charge all rights under the secured documents being the facility letter,the debenture or the duty of care agreement.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Subcharge
    Erstellt am 01. Apr. 1999
    Geliefert am 21. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any transaction document (as defined)
    Kurze Angaben
    Submortgage of the debenture dated 1ST february 1999 between the company and bourne end property trading limied and all rights under the secured documents (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wuttemberische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 13TH april 1999
    Erstellt am 30. März 1999
    Geliefert am 14. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the company to the chargee under (I) the participation agreement to be dated on or about the date of execution of the standard security entered into between the company and the chargee; (ii) this standard security; or (iii) any other document designated by the company and the chargee as being a "transaction document"
    Kurze Angaben
    Subjects k/a and forming 247 main street coatbridge t/n-LAN2112 together with (a) the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Subcharge
    Erstellt am 30. Sept. 1998
    Geliefert am 13. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any transaction document (as therein defined)
    Kurze Angaben
    Subcharge of the debenture dated on or about the date of the subcharge executed by bourne end (hyde) limited in favour or the company and all rights under the secured documents (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 13. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Ausländisches Insolvenzverfahren
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Eamonn Richardson
    1 Stokes Place
    St Stephen'S Green
    Dublin 2
    Praktiker
    1 Stokes Place
    St Stephen'S Green
    Dublin 2
    Kieran Wallace
    1 Stokes Place
    2 St Stephens Green
    Dublin
    Praktiker
    1 Stokes Place
    2 St Stephens Green
    Dublin

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0