IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Ausländische Gesellschaft |
| Unternehmensnummer | FC016044 |
| Gerichtsbarkeit | Vereinigtes Königreich |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Wo befindet sich IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Branch Registration Refer To Parent Registry Ireland |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED | 29. Apr. 2009 | 29. Apr. 2009 |
| ANGLO IRISH BANK CORPORATION PLC | 01. Mai 1991 | 01. Mai 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Sept. 2012 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED ist ein ausländisches Unternehmen
| Buchführungspflicht für ausländische Unternehmen | |
|---|---|
| Art des ausländischen Jahresabschlusses | Es gelten die Rechnungslegungsvorschriften des Ursprungslandes |
| Bedingungen für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses | Veröffentlichungsdatum der Rechnungsabschlüsse vom Unternehmen geliefert |
| Beginn des Geschäftsjahres | Tag: 1 Monat: 10 |
| Ende des Geschäftsjahres | Tag: 30 Monat: 9 |
| Monat: | 9 |
| Rechtsform | Re-Registration As A Private Company Following Nationalisation |
| Ist ein Kredit- oder Finanzinstitut | Nein |
| Ursprungsregisterland | IRELAND |
| Registrierungsort | Companies Reg. Office Dublin |
| Unternehmensnummer | 22045 |
Welche sind die letzten Einreichungen für IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Änderungen für eine britische Niederlassung - BR000969 Address Change 10 old jewry, london, , EC2R 8DN,30. Juni 2014 | 3 Seiten | OSCH01 | ||
Ernennung eines Liquidators einer ausländischen Gesellschaft | 3 Seiten | OSLQ01 | ||
Liquidation einer ausländischen Gesellschaft | 3 Seiten | OSLQ03 | ||
Beendigung der Bestellung von Frank Daly als Geschäftsführer | 2 Seiten | OSTM01 | ||
Ernennung eines Direktors | 2 Seiten | OSAP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Donal O'connor als Geschäftsführer | 2 Seiten | OSTM01 | ||
Der Standort des Pfandrechtsregisters wurde geändert | 1 Seiten | OSAD02 | ||
Ernennung eines Direktors | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Ernennung eines Direktors | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Ernennung eines Direktors | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Maxwell Barrett als Sekretär | 2 Seiten | OSTM02 | ||
Änderung der Details des Direktors für Arthur Michael Robert Aynsley am 01. Nov. 2011 | 3 Seiten | OSCH03 | ||
Ernennung von Philip Brady zum Sekretär | 4 Seiten | OSAP03 | ||
Ernennung eines Direktors | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 181 Seiten | AA | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 183 Seiten | AA | ||
Änderung der Satzungsdokumente am 14. Okt. 2011 | 36 Seiten | OSCC01 | ||
Änderung des eingetragenen Namens einer ausländischen Gesellschaft am 19. Okt. 2011 von {change_name} | 4 Seiten | OSNM01 | ||
Verschiedenes Notification of overseas company closure due to registration in multiple jurisdictions | 1 Seiten | MISC | ||
Verschiedenes Multiple registrations- confirmation of the company in respect of which it intends to make future filings | 1 Seiten | MISC | ||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Harwerth als Geschäftsführer | 4 Seiten | OSTM01 | ||
Übergangsrückblick für BR013942 - Person, die zur Vertretung befugt ist, Paul Gareth Kennedy Cuilin Allies River Road Rathmichael Dublin Ireland | Seiten | OSTN01-PAR | ||
Übergangsrückblick für BR013942 - Änderungen an der Niederlassung im Vereinigten Königreich, Address Change 14/18 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7BA | Seiten | OSTN01-CHNG | ||
Übergangsrückblick für BR013942 - Änderungen an der Niederlassung im Vereinigten Königreich, Business Change Null | Seiten | OSTN01-CHNG | ||
Übergangsrückblick für BR013942 - Person, die zur Vertretung befugt ist, Alan Martin Dukes C/O Anglo Irish Bank Corporation Limited Connaught House Dublin 4 Ireland | Seiten | OSTN01-PAR | ||
Wer sind die Geschäftsführer von IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADY, Philip | Sekretär | Stephen Court 18-21 St Stephens Greend Dublin 2 C/O Irish Bank Resolution Corporation Limited Ireland | 170774300001 | |||||||
| AYNSLEY, Arthur Michael Royal | Geschäftsführer | Malborough Road Glengeary Limasol Dublin Ireland | Ireland | Australian | 159026000002 | |||||
| CAWLEY, Noel | Geschäftsführer | Eadestown Naas Newpark Lodge Stud Kildare Ireland | Ireland | Irish | 159026270001 | |||||
| DALY, Frank Maurice | Geschäftsführer | Rathdown Park Terenure 85 Dublin 6w Ireland | Ireland | Irish | 159026180001 | |||||
| DUKES, Alan Martin | Geschäftsführer | Tully West Kildare Tully West Ireland | Ireland | Irish | 159023840001 | |||||
| EAMES, Aidan | Geschäftsführer | Drumnigh Portmarnock Drumnigh House Dublin Ireland | Ireland | Irish | 159026460001 | |||||
| ELLINGHAM, Oliver Bernard | Geschäftsführer | c/o Irish Bank Resolution Corporation Limited 18-21 St Stephen's Green Dublin 2 Stephen Court Ireland | United Kingdom | British | 177523800001 | |||||
| HORAN, Maurice Benedict | Geschäftsführer | c/o Irish Bank Resolution Corporation Limited 18-21 St Stephen's Green Dublin 2 Stephen Court Ireland | Ireland | Irish | 208836870001 | |||||
| KEANE, Maurice Augustine | Geschäftsführer | Manor Green Rathfarnham 6 Dublin 16 Ireland | Ireland | British | 54089110001 | |||||
| KENNEDY, Paul Gareth | Geschäftsführer | Allies River Road Old Conna Rathmichael Cuilin Dublin Ireland | Ireland | Irish | 159026370001 | |||||
| MCGREAL, Roger | Geschäftsführer | Stephen Court 18-21 St Stephens Greend Dublin 2 C/O Irish Bank Resolution Corporation Limited Ireland | Ireland | Irish | 66616180001 | |||||
| RIDGWAY, Alan | Geschäftsführer | c/o Irish Bank Resolution Corporation Limited 18-21 St Stephen's Green Dublin 2 Stephen Court Ireland | Luxembourg | Irish | 172998940001 | |||||
| BARRETT, Maxwell Jude | Sekretär | Roebuck Road Clonskeagh 51 The Palms Dublin 14 Ireland | British | 159026540001 | ||||||
| DALY, Bernard | Sekretär | Collins Avenue West Dublin 253 9 Ireland | British | 159026640001 | ||||||
| MERCER, Natasha Caulfield | Sekretär | Belmont Avenue Donnybrook 44 Dublin 4 Ireland | British | 159026840001 | ||||||
| MURPHY, Ronan | Sekretär | 43 Clonkeen Road Blackrock IRISH Co Dublin Ireland | British | 19817800001 | ||||||
| BARRETT, William Richard | Geschäftsführer | 4 Homelee Serpentine Avenue IRISH Ballsbridge Dublin 4 Ireland | Irish | 47328110001 | ||||||
| BRADSHAW, Lar | Geschäftsführer | Church Road Killiney Airlie Dublin Ireland | Ireland | Irish | 159018640001 | |||||
| BROWNE, Thomas | Geschäftsführer | Brighton Road Foxrock Ferney Hill Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | 215937180001 | |||||
| COLEBY, Anthony Laurie | Geschäftsführer | Horse Fair OX16 0AH Banbury Country Chambers Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 144752200001 | |||||
| CURRAN, Maurice Robert | Geschäftsführer | Woodsise Drive Castle Park Rathfarnham 14 Dublin 14 Ireland | Ireland | Irish | 159001960001 | |||||
| DALY, Frank Maurice | Geschäftsführer | Rathdown Park Terenure 85 Dublin 6w Ireland | Ireland | Irish | 159026180001 | |||||
| DRUMM, David Kenneth | Geschäftsführer | Abington Malahide 20 Dublin Ireland | Ireland | Irish | 159018230001 | |||||
| DRURY, Fintan Colm | Geschäftsführer | Russian Village Kilquade Glenaphouca Wicklow Ireland | Ireland | Irish | 171446720001 | |||||
| FITZPATRICK, Sean Patrick | Geschäftsführer | Camaderry Whitshed Road IRISH Greystones Co Wicklow Ireland | Ireland | Irish | 2885780001 | |||||
| HARWERTH, Elizabeth Noel | Geschäftsführer | c/o Anglo Irish Bank Corporation Limited Burlington Road Dublin 4 Connaught House Ireland | Irish | 161335320001 | ||||||
| HERATY, Anne | Geschäftsführer | Highfield House Rathgar 2 Dublin 6 Ireland | Ireland | Irish | 159019080001 | |||||
| JACOB, Michael Desmond | Geschäftsführer | Greyfield Newtownpark Avenue IRISH Blackrock Co. Dublin Ireland | Irish | 47328080001 | ||||||
| JAMAL, Patrica | Geschäftsführer | St. Margaret's Close Putney SW15 6HL London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 159015880001 | |||||
| KILLEN, Peter Richard | Geschäftsführer | 3 Killeen Terrace IRISH Malahide Co. Dublin Ireland | Irish | 47328090001 | ||||||
| MCATEER, William Anthony | Geschäftsführer | 7 Highfield Court IRISH Marley Grange Dublin 16 Ireland | Irish | 47328070001 | ||||||
| MCCANN, William Mary | Geschäftsführer | Kind Edward Road Bray Kylemore Wicklow Ireland | Irish | 47414720002 | ||||||
| MCGANN, Gary | Geschäftsführer | Stonehouse Donnybrook Cherryfield Dublin 4 Ireland | Ireland | Irish | 41200650001 | |||||
| MURPHY, Augustine Gerard | Geschäftsführer | Meevagh Asgard Road IRISH Howth Co Dublin Ireland | Irish | 19817830001 | ||||||
| MURRAY, Peter Cyril | Geschäftsführer | Ash Pembroke Gardens IRISH Ballsbridge Dublin 4 Ireland | Irish | 47328130002 |
Hat IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 23. Dez. 2008 Geliefert am 03. Jan. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon account number: 13543420 sort code: 20-77-67 account name: bb re anglo irish bank corporation PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subcharge | Erstellt am 22. Apr. 1999 Geliefert am 27. Apr. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any capacity whatsoever of the company to the chargee (the "participant") under any transaction document (as defined) | |
Kurze Angaben The debenture dated 31ST december creating a charge by way of legal submortgage over albion house commercial way woking t/n's SY324753 and SY637181,122 thorpe road norwich t/n NK188201,norfolk house queensway birmingham t/n WK118424 and norwich union house,plymouth by way of first fixed charge all rights under the secured documents being the facility letter,the debenture or the duty of care agreement. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subcharge | Erstellt am 01. Apr. 1999 Geliefert am 21. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any transaction document (as defined) | |
Kurze Angaben Submortgage of the debenture dated 1ST february 1999 between the company and bourne end property trading limied and all rights under the secured documents (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on the 13TH april 1999 | Erstellt am 30. März 1999 Geliefert am 14. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the company to the chargee under (I) the participation agreement to be dated on or about the date of execution of the standard security entered into between the company and the chargee; (ii) this standard security; or (iii) any other document designated by the company and the chargee as being a "transaction document" | |
Kurze Angaben Subjects k/a and forming 247 main street coatbridge t/n-LAN2112 together with (a) the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subcharge | Erstellt am 30. Sept. 1998 Geliefert am 13. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any transaction document (as therein defined) | |
Kurze Angaben Subcharge of the debenture dated on or about the date of the subcharge executed by bourne end (hyde) limited in favour or the company and all rights under the secured documents (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausländisches Insolvenzverfahren |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0