VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Ausländisches Unternehmen
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC
    UnternehmensstatusUmwandlung / Auflösung
    RechtsformAusländische Gesellschaft
    Unternehmensnummer FC018124
    GerichtsbarkeitVereinigtes Königreich
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Wo befindet sich VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2711 Centreville Road
    Suite 400
    Wilmington
    Delaware De 19808
    Usa
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    VIRGIN MEDIA (UK) GROUP, INC07. Mai 199707. Mai 1997
    CABLETEL UK GROUP, INC.16. Feb. 199616. Feb. 1996
    OCOM SUB II, INC.15. Dez. 199315. Dez. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC ist ein ausländisches Unternehmen

    Buchführungspflicht für ausländische Unternehmen
    Art des ausländischen JahresabschlussesDie Rechnungslegungsvorschriften des Ursprungslandes gelten nicht
    Bedingungen für die Veröffentlichung des JahresabschlussesVon Companies House zugewiesenes Rechnungsabschlussreferenzdatum
    GeschäftstätigkeitTo Engage In Any Legal Activity
    RechtsformLimited Liability Company
    Ist ein Kredit- oder FinanzinstitutNein
    Regiert vonGeneral Corporation Law Of State Of Delaware
    UrsprungsregisterlandUNITED STATES
    RegistrierungsortOffice Of The Secretary Of State For Delaware
    UnternehmensnummerN/A

    Welche sind die letzten Einreichungen für VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Schließung der britischen Niederlassung(en) BR003964 und der ausländischen Gesellschaft FC018124 am 18. Dez. 2015

    2 SeitenOSDS01

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    3 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    3 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    3 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    18 SeitenAA

    Änderung des eingetragenen Namens einer ausländischen Gesellschaft am 28. Feb. 2015 von {change_name}

    4 SeitenOSNM01

    Änderung der Satzungsdokumente am 17. Dez. 2014

    14 SeitenOSCC01

    Änderungen für eine ausländische Gesellschaft - Change in Legal Form 17/12/14 Private Company Limited by Shares

    SeitenOSCH02

    Änderungen für eine ausländische Gesellschaft - Ic Change 17/12/14

    4 SeitenOSCH02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    21 SeitenAA

    Ernennung eines Direktors

    3 SeitenOSAP01

    Beendigung der Bestellung von Caroline Withers als Geschäftsführer

    2 SeitenOSTM01

    Beendigung der Bestellung von Robert Gale als Geschäftsführer

    2 SeitenOSTM01

    Ernennung eines Direktors

    3 SeitenOSAP01

    Änderungen für eine ausländische Gesellschaft - 160 Greentree Drive, Suite 101 Dover, Delaware 19904 Usa, United States

    4 SeitenOSCH02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    30 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 14. März 2013

    3 SeitenOSCH03

    Beendigung der Bestellung von Joanne Tillbrook als Geschäftsführer

    2 SeitenOSTM01

    Ernennung eines Direktors

    3 SeitenOSAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    20 SeitenAA

    Ernennung eines Direktors

    5 SeitenOSAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Mackenzie als Geschäftsführer

    3 SeitenOSTM01

    Änderung der Angaben des Sekretärs für Gillian Elizabeth James am 16. Sept. 2011

    4 SeitenOSCH05

    Änderung der Details des Direktors für Robert Charles Gale am 16. Sept. 2011

    5 SeitenOSCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    21 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    British72139660003
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish182167230001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Sekretär
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Geschäftsführer
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    DELLAROCCO, Thoams Stephan
    7a Woodway
    Merrow
    GU1 2TF Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    7a Woodway
    Merrow
    GU1 2TF Guildford
    Surrey
    American48933280001
    DEW, Bryony
    2 Winton Road
    GU9 9QW Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Winton Road
    GU9 9QW Farnham
    Surrey
    British70776760001
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    GIESEN, Douglas Henry
    399 Albert Drive
    G41 4SA Glasgow
    Geschäftsführer
    399 Albert Drive
    G41 4SA Glasgow
    Us45775100001
    HEIDARY, Hamid Reza
    Fairways West Hill Golf Course
    Bagshot Road
    GU22 0QZ Worplesdon Hill
    Surrey
    Geschäftsführer
    Fairways West Hill Golf Course
    Bagshot Road
    GU22 0QZ Worplesdon Hill
    Surrey
    American48966390001
    HINDLEY, Alan
    Cedar Lodge Coldmoorholme Lane
    SL8 5PS Bourne End
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Cedar Lodge Coldmoorholme Lane
    SL8 5PS Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish59366960001
    JAIN, Dinesh
    Redcote
    Sheath Lane
    KT22 0RA Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    Redcote
    Sheath Lane
    KT22 0RA Oxshott
    Surrey
    American48933260002
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    MACDONALD, Stephen
    8 Vale Coppice
    Ramsbotham
    BL0 9FJ Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Vale Coppice
    Ramsbotham
    BL0 9FJ Bury
    Lancashire
    British71437880001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Geschäftsführer
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MCKELLAR, Ronald Alexander
    Halstead
    Stratfield Saye
    RG7 2EJ Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Halstead
    Stratfield Saye
    RG7 2EJ Reading
    Berkshire
    British7345780001
    MELLY, Gregory Kevin
    Thistledown
    Abbotswood Chase
    GU1 1XA Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Thistledown
    Abbotswood Chase
    GU1 1XA Guildford
    Surrey
    British48933270001
    PEGELLA, Maurice Vondy
    7 Grays Lane
    KT21 1BS Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    7 Grays Lane
    KT21 1BS Ashtead
    Surrey
    British102510960001
    ROBERTS, Gareth Nigel Christopher
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    Geschäftsführer
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    British145824690001
    ROSS, Stuart
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    Geschäftsführer
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    EnglandBritish20168110001
    RYAN, Terrence Michael
    Penarth House
    Cliff Parade
    CF64 5BP Penarth
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    Penarth House
    Cliff Parade
    CF64 5BP Penarth
    South Glamorgan
    Us Citizen40077290002
    SMITH, Timothy
    Mayfield House Hungerford Hill
    Lambourn
    RG16 7NP Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Mayfield House Hungerford Hill
    Lambourn
    RG16 7NP Newbury
    Berkshire
    British60222820001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164134250001
    WAGNER, Steven
    Wentworth Gate East Drive
    GU25 4JY Virginia Water
    Surrey
    Geschäftsführer
    Wentworth Gate East Drive
    GU25 4JY Virginia Water
    Surrey
    American44170170001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish140137570002
    WOOD, Leigh
    The Priory 10 Hambledon Park
    Hambledon
    GU8 4ER Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Priory 10 Hambledon Park
    Hambledon
    GU8 4ER Godalming
    Surrey
    American53880530001

    Hat VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Second assignment agreement relating to inter-company loans
    Erstellt am 27. Sept. 2001
    Geliefert am 08. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations at any time due, owing or incurred by the obligor to any secured party under the finance documents (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    All its rights title and interest present and future in and to and the benefit of the intra group loans and its right to receive sums thereunder including without limitation all such rights as may revert to the company upon the discharge and release of the ntl UK intra-group loan assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited as Security Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Second Security Trust Agreement
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An assignment agreement relating to inter-company loans (the "intra-group loan assignment") between the assignor and security trustee.
    Erstellt am 21. Feb. 2001
    Geliefert am 22. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations owing to the secured parties or to the security trustee (whether for it's own account or as trustee for the secured parties) by the obligors under or pursuant to the finance documents
    Kurze Angaben
    All right title and interest present and future in and to and the benefit of, the intra-group loans (as defined) and all rights to receive sums thereunder.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited as Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Security Trust Agreement
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 17. Okt. 1997
    Geliefert am 30. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the company (the "chargor") may now or hereafter have to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries (and whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the facility documents including any liability in respect of any further advances made thereunder (the "secured obligations")
    Kurze Angaben
    See schedules attached to form M395 for details of all the property). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A deposit agreement
    Erstellt am 20. Aug. 1997
    Geliefert am 21. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the counter-indemnity or this deposit agreement
    Kurze Angaben
    Fixed charge all the chargor's right,title and interest in and to all monies on the date of the deposit agreement or at any time thereafter during the subsistence of the deposit agreement standing to the credit of:(a) any account which may from time to time be opened in order to effect certain time deposits to be made with chase manhattan international limited at its 125 london wall,london EC2Y 5AJ office as security for the chargor's obligations under the counter indemnity;and (b) any account opened by the bank pursuant to clause 7 of the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhattan Bank
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit agreement
    Erstellt am 29. Mai 1997
    Geliefert am 17. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the counter-indemnity (as defined) or the deposit agreement
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to all monies standing to the credit of any account from time to time opened to effect certain time deposits to be made with chase manhattan international limited and any account opened by the bank pursuant to clause 7 of the deposit agreement and all rights and benefits accruing or arising in connection with the deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhattan Bank
    Transaktionen
    • 17. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0