VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC
Überblick
| Unternehmensname | VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
| Rechtsform | Ausländische Gesellschaft |
| Unternehmensnummer | FC018124 |
| Gerichtsbarkeit | Vereinigtes Königreich |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Wo befindet sich VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2711 Centreville Road Suite 400 Wilmington Delaware De 19808 Usa |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| VIRGIN MEDIA (UK) GROUP, INC | 07. Mai 1997 | 07. Mai 1997 |
| CABLETEL UK GROUP, INC. | 16. Feb. 1996 | 16. Feb. 1996 |
| OCOM SUB II, INC. | 15. Dez. 1993 | 15. Dez. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC ist ein ausländisches Unternehmen
| Buchführungspflicht für ausländische Unternehmen | |
|---|---|
| Art des ausländischen Jahresabschlusses | Die Rechnungslegungsvorschriften des Ursprungslandes gelten nicht |
| Bedingungen für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses | Von Companies House zugewiesenes Rechnungsabschlussreferenzdatum |
| Geschäftstätigkeit | To Engage In Any Legal Activity |
| Rechtsform | Limited Liability Company |
| Ist ein Kredit- oder Finanzinstitut | Nein |
| Regiert von | General Corporation Law Of State Of Delaware |
| Ursprungsregisterland | UNITED STATES |
| Registrierungsort | Office Of The Secretary Of State For Delaware |
| Unternehmensnummer | N/A |
Welche sind die letzten Einreichungen für VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Schließung der britischen Niederlassung(en) BR003964 und der ausländischen Gesellschaft FC018124 am 18. Dez. 2015 | 2 Seiten | OSDS01 | ||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 18 Seiten | AA | ||
Änderung des eingetragenen Namens einer ausländischen Gesellschaft am 28. Feb. 2015 von {change_name} | 4 Seiten | OSNM01 | ||
Änderung der Satzungsdokumente am 17. Dez. 2014 | 14 Seiten | OSCC01 | ||
Änderungen für eine ausländische Gesellschaft - Change in Legal Form 17/12/14 Private Company Limited by Shares | Seiten | OSCH02 | ||
Änderungen für eine ausländische Gesellschaft - Ic Change 17/12/14 | 4 Seiten | OSCH02 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 21 Seiten | AA | ||
Ernennung eines Direktors | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Caroline Withers als Geschäftsführer | 2 Seiten | OSTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Robert Gale als Geschäftsführer | 2 Seiten | OSTM01 | ||
Ernennung eines Direktors | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Änderungen für eine ausländische Gesellschaft - 160 Greentree Drive, Suite 101 Dover, Delaware 19904 Usa, United States | 4 Seiten | OSCH02 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 30 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 14. März 2013 | 3 Seiten | OSCH03 | ||
Beendigung der Bestellung von Joanne Tillbrook als Geschäftsführer | 2 Seiten | OSTM01 | ||
Ernennung eines Direktors | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 20 Seiten | AA | ||
Ernennung eines Direktors | 5 Seiten | OSAP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Robert Mackenzie als Geschäftsführer | 3 Seiten | OSTM01 | ||
Änderung der Angaben des Sekretärs für Gillian Elizabeth James am 16. Sept. 2011 | 4 Seiten | OSCH05 | ||
Änderung der Details des Direktors für Robert Charles Gale am 16. Sept. 2011 | 5 Seiten | OSCH03 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 21 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | British | 72139660003 | ||||||
| DUNN, Robert Dominic | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | England | British | 179134020002 | |||||
| HIFZI, Mine Ozkan | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | England | British | 182167230001 | |||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Sekretär | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | British | 47785600002 | ||||||
| CARTER, Stephen Andrew | Geschäftsführer | 22 Melville Road Barnes SW13 9RJ London | United Kingdom | British | 59445920002 | |||||
| DELLAROCCO, Thoams Stephan | Geschäftsführer | 7a Woodway Merrow GU1 2TF Guildford Surrey | American | 48933280001 | ||||||
| DEW, Bryony | Geschäftsführer | 2 Winton Road GU9 9QW Farnham Surrey | British | 70776760001 | ||||||
| GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | England | British | 96956740001 | |||||
| GIESEN, Douglas Henry | Geschäftsführer | 399 Albert Drive G41 4SA Glasgow | Us | 45775100001 | ||||||
| HEIDARY, Hamid Reza | Geschäftsführer | Fairways West Hill Golf Course Bagshot Road GU22 0QZ Worplesdon Hill Surrey | American | 48966390001 | ||||||
| HINDLEY, Alan | Geschäftsführer | Cedar Lodge Coldmoorholme Lane SL8 5PS Bourne End Buckinghamshire | England | British | 59366960001 | |||||
| JAIN, Dinesh | Geschäftsführer | Redcote Sheath Lane KT22 0RA Oxshott Surrey | American | 48933260002 | ||||||
| KELHAM, David William | Geschäftsführer | Chastilian Gough Road GU51 4LJ Fleet Hampshire | England | British | 87146390001 | |||||
| MACDONALD, Stephen | Geschäftsführer | 8 Vale Coppice Ramsbotham BL0 9FJ Bury Lancashire | British | 71437880001 | ||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MCKELLAR, Ronald Alexander | Geschäftsführer | Halstead Stratfield Saye RG7 2EJ Reading Berkshire | British | 7345780001 | ||||||
| MELLY, Gregory Kevin | Geschäftsführer | Thistledown Abbotswood Chase GU1 1XA Guildford Surrey | British | 48933270001 | ||||||
| PEGELLA, Maurice Vondy | Geschäftsführer | 7 Grays Lane KT21 1BS Ashtead Surrey | British | 102510960001 | ||||||
| ROBERTS, Gareth Nigel Christopher | Geschäftsführer | 20 Aspen Lodge Abbots Walk W8 5UN London | British | 145824690001 | ||||||
| ROSS, Stuart | Geschäftsführer | 15 Mckay Road SW20 0HT London | England | British | 20168110001 | |||||
| RYAN, Terrence Michael | Geschäftsführer | Penarth House Cliff Parade CF64 5BP Penarth South Glamorgan | Us Citizen | 40077290002 | ||||||
| SMITH, Timothy | Geschäftsführer | Mayfield House Hungerford Hill Lambourn RG16 7NP Newbury Berkshire | British | 60222820001 | ||||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| WAGNER, Steven | Geschäftsführer | Wentworth Gate East Drive GU25 4JY Virginia Water Surrey | American | 44170170001 | ||||||
| WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 140137570002 | |||||
| WOOD, Leigh | Geschäftsführer | The Priory 10 Hambledon Park Hambledon GU8 4ER Godalming Surrey | American | 53880530001 |
Hat VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Confirmation deed | Erstellt am 15. Apr. 2010 Geliefert am 29. Apr. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second assignment agreement relating to inter-company loans | Erstellt am 27. Sept. 2001 Geliefert am 08. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations at any time due, owing or incurred by the obligor to any secured party under the finance documents (all terms as defined) | |
Kurze Angaben All its rights title and interest present and future in and to and the benefit of the intra group loans and its right to receive sums thereunder including without limitation all such rights as may revert to the company upon the discharge and release of the ntl UK intra-group loan assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An assignment agreement relating to inter-company loans (the "intra-group loan assignment") between the assignor and security trustee. | Erstellt am 21. Feb. 2001 Geliefert am 22. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations owing to the secured parties or to the security trustee (whether for it's own account or as trustee for the secured parties) by the obligors under or pursuant to the finance documents | |
Kurze Angaben All right title and interest present and future in and to and the benefit of, the intra-group loans (as defined) and all rights to receive sums thereunder.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Okt. 1997 Geliefert am 30. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Each and every liability which the company (the "chargor") may now or hereafter have to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries (and whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the facility documents including any liability in respect of any further advances made thereunder (the "secured obligations") | |
Kurze Angaben See schedules attached to form M395 for details of all the property). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deposit agreement | Erstellt am 20. Aug. 1997 Geliefert am 21. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the counter-indemnity or this deposit agreement | |
Kurze Angaben Fixed charge all the chargor's right,title and interest in and to all monies on the date of the deposit agreement or at any time thereafter during the subsistence of the deposit agreement standing to the credit of:(a) any account which may from time to time be opened in order to effect certain time deposits to be made with chase manhattan international limited at its 125 london wall,london EC2Y 5AJ office as security for the chargor's obligations under the counter indemnity;and (b) any account opened by the bank pursuant to clause 7 of the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement | Erstellt am 29. Mai 1997 Geliefert am 17. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the counter-indemnity (as defined) or the deposit agreement | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to all monies standing to the credit of any account from time to time opened to effect certain time deposits to be made with chase manhattan international limited and any account opened by the bank pursuant to clause 7 of the deposit agreement and all rights and benefits accruing or arising in connection with the deposits. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0