PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
| Rechtsform | Ausländische Gesellschaft |
| Unternehmensnummer | FC021877 |
| Externe Registrierungsnummer | CR 89715 |
| Gerichtsbarkeit | Vereinigtes Königreich |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Wo befindet sich PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Maples And Calder Ugland House PO BOX 309 George Town Grand Cayman Cayman Islands Cayman Islands |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 15. Aug. 2021 |
PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED ist ein ausländisches Unternehmen
| Buchführungspflicht für ausländische Unternehmen | |
|---|---|
| Art des ausländischen Jahresabschlusses | Die Rechnungslegungsvorschriften des Ursprungslandes gelten nicht |
| Bedingungen für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses | Von Companies House zugewiesenes Rechnungsabschlussreferenzdatum |
| Geschäftstätigkeit | Toissue Debt Securities & On-Lend Proceeds |
| Rechtsform | Exempt Company Withg Limited Liability |
| Ist ein Kredit- oder Finanzinstitut | Nein |
| Regiert von | Cayman Islands |
| Ursprungsregisterland | CAYMAN ISLANDS |
| Registrierungsort | Register Of Cayman Islands Companies |
| Unternehmensnummer | CR 89715 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Schließung der britischen Niederlassung(en) BR005024 und der ausländischen Gesellschaft FC021877 am 27. März 2023 | 3 Seiten | OSDS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Francesca Ann Appleby als Sekretär am 22. Aug. 2022 | 2 Seiten | OSTM02 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 15. Aug. 2021 | 22 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Daniel Jonathan Wynne als Geschäftsführer am 30. Juni 2021 | 2 Seiten | OSTM01 | ||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 16. Aug. 2020 | 21 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 18. Aug. 2019 | 22 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 19. Aug. 2018 | 22 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 19. Aug. 2017 | 25 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Daniel Jonathan Wynne am 05. Dez. 2017 | 3 Seiten | OSCH03 | ||
Ernennung von Mr Daniel Jonathan Wynne zum Direktor am 21. Apr. 2017 | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Mark Howard Filer als Geschäftsführer am 21. Apr. 2017 | 2 Seiten | OSTM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 22. Aug. 2016 | 24 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 22. Aug. 2015 | 23 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 23. Aug. 2014 | 22 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Wilmington Trust Sp Services (London) Limited als Geschäftsführer am 09. Okt. 2014 | 2 Seiten | OSTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Dean Edward John Merritt als Geschäftsführer am 08. Okt. 2014 | 2 Seiten | OSTM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Claire Louise Harris als Sekretär am 07. Okt. 2014 | 2 Seiten | OSTM02 | ||
Ernennung von Francesca Ann Appleby zum Sekretär am 07. Okt. 2014 | 3 Seiten | OSAP03 | ||
Ernennung eines Direktors | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Ernennung eines Direktors | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 17. Aug. 2013 | 21 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen Billingham als Geschäftsführer | 2 Seiten | OSTM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton On Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton On Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| APPLEBY, Francesca Ann | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire | British | 191946720001 | ||||||
| ARMITAGE, Helen Tyrrell | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire | British | 166847910001 | ||||||
| CROSS, Anthony | Sekretär | 38 The Lane Spinkhill S21 3YF Sheffield South Yorkshire | British | 1812400001 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire | British | 175820210001 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | 23 Whitehouse Drive WS13 8FE Lichfield Staffordshire | British | 81789210002 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton On Trent Jubilee House Staffordshire Uk | British | 117216940001 | ||||||
| BILLINGHAM, Stephen Robert | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire | Uk | British | 163365820001 | |||||
| BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge | Geschäftsführer | 8 Moore Street SW3 2QN London | United Kingdom | British | 53682420001 | |||||
| DUTTON, Philip | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton On Trent Jubilee House Staffordshire Uk | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| FILER, Mark Howard | Geschäftsführer | c/o Wilmington Trust Sp Services (London) Limited 1 Kings Arms Yard EC2R 7AF London Third Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 108927600003 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Geschäftsführer | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MERRITT, Dean Edward John | Geschäftsführer | c/o Talbot Highes Mckillop Llp Snow Hill EC1A 2AY London 6 United Kingdom | United Kingdom | British | 141247230001 | |||||
| PRESTON, Neil David | Geschäftsführer | Postern Road Tatenhill DE13 9SJ Burton On Trent 57 Staffordshire | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| SANDS, John Robert | Geschäftsführer | 11 Falcon Lane Norton TS20 1LS Stockton On Tees | United Kingdom | British | 141561650001 | |||||
| THORLEY, Giles Alexander | Geschäftsführer | Charlton Manor Ashley Road Charlton Kings GL52 6NS Cheltenham Gloucestershire | Gb-Eng | British | 81928120001 | |||||
| TURNBULL, Ronald | Geschäftsführer | 16 Willow Road Dairy Lane Estate DH4 5QF Houghton Le Spring Tyne & Wear | British | 63331360001 | ||||||
| WHITESIDE, Roger Mark | Geschäftsführer | Second Avenue Centrum One Hundred DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire | England | British | 128819260001 | |||||
| WYNNE, Daniel Jonathan | Geschäftsführer | c/o Wilmington Ttust Sp Services (London) Limited 1 King's Arm Yard EC2R 7AF London Third Floor | England | British | 101879110005 | |||||
| WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LONDON) LIMITED | Geschäftsführer | King's Arms Yard EC2R 7AF London Third Floor 1 | 24311810024 |
Hat PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| The eighth supplemental issuer deed of charge | Erstellt am 01. Aug. 2005 Geliefert am 12. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the issuer security trustee, the note trustee, the class a noteholders and all other parties as defined on the form 395 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right, title, interest and benefit, present and future, in, to and under the second new notes subscription agreement, the seventh supplemental punch taverns b deed of charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Seventh supplemental issuer deed of charge | Erstellt am 09. Mai 2005 Geliefert am 10. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the issuer security trustee, the note trustee, the class a noteholders and all other parties as defined on the form 395 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title interest and benefit in and to all moneys standing to the credit of the issuer transaction account, the issuer cash collateral account and the prefunding account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second supplemental issuer deed of charge made between the company, bankers trustee company limited and deutsche bank international trust co. (Jersey) limited (the note trustee) | Erstellt am 23. Dez. 1999 Geliefert am 12. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) under the second supplemental deed of charge | |
Kurze Angaben All rights title interest and benefit present and future in to and under the supplemental pubmaster deed of charge including all rights to receive payment of any amounts which may become payable to the issuer thereunder and all payments received by the issuer thereunder. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0