NTL (TRIANGLE) LLC
Überblick
| Unternehmensname | NTL (TRIANGLE) LLC |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
| Rechtsform | Ausländische Gesellschaft |
| Unternehmensnummer | FC023131 |
| Externe Registrierungsnummer | NONE |
| Gerichtsbarkeit | Vereinigtes Königreich |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Wo befindet sich NTL (TRIANGLE) LLC?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 251 Little Falls Drive Wilmington Delaware De 19808 United States |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NTL (TRIANGLE) LLC?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
NTL (TRIANGLE) LLC ist ein ausländisches Unternehmen
| Buchführungspflicht für ausländische Unternehmen | |
|---|---|
| Art des ausländischen Jahresabschlusses | Die Rechnungslegungsvorschriften des Ursprungslandes gelten nicht |
| Bedingungen für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses | Von Companies House zugewiesenes Rechnungsabschlussreferenzdatum |
| Geschäftstätigkeit | Bank Borrowing, Investment And Inter-Company Funding |
| Rechtsform | Private Limited Liability Company |
| Ist ein Kredit- oder Finanzinstitut | Nein |
| Regiert von | Limited Liability Act Of State Of Delaware |
| Ursprungsregisterland | UNITED STATES |
| Registrierungsort | Office Of The Secretary Of State Of Delaware |
| Unternehmensnummer | NONE |
Welche sind die letzten Einreichungen für NTL (TRIANGLE) LLC?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Schließung der britischen Niederlassung(en) BR006009 und der ausländischen Gesellschaft FC023131 am 02. Dez. 2020 | 2 Seiten | OSDS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Severina-Pompilia Pascu als Geschäftsführer am 16. Nov. 2020 | 2 Seiten | OSTM01 | ||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||
Ernennung von Caroline Bernadette Elizabeth Withers zum Direktor am 23. Apr. 2020 | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Ernennung von Roderick Gregor Mcneil zum Direktor am 09. März 2020 | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Ernennung von Severina-Pompilia Pascu zum Direktor am 03. März 2020 | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Beendigung der Bestellung von William Thomas Castell als Geschäftsführer am 09. März 2020 | 2 Seiten | OSTM01 | ||
Änderungen für eine britische Niederlassung - BR006009 Address Change Media house bartley wood, business park, hook, hampshire, RG27 9UP,02. Dez. 2019 | 3 Seiten | OSCH01 | ||
Ernennung von William Thomas Castell zum Direktor am 09. Sept. 2019 | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Robert Dominic Dunn als Geschäftsführer am 09. Sept. 2019 | 2 Seiten | OSTM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 21 Seiten | AA | ||
Änderungen für eine ausländische Gesellschaft - Ic Change 17/05/19 | 4 Seiten | OSCH02 | ||
Änderung der Satzungsdokumente am 17. Mai 2019 | 13 Seiten | OSCC01 | ||
Änderungen für eine ausländische Gesellschaft - Ic Change 17/05/19 | 4 Seiten | OSCH02 | ||
Änderungen für eine ausländische Gesellschaft - Ic Change 10/07/18 | 2 Seiten | OSCH02 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 18 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 18 Seiten | AA | ||
Änderungen für eine ausländische Gesellschaft - 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware De 19808, Usa | 4 Seiten | OSCH02 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 17 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 18 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 20 Seiten | AA | ||
Ernennung eines Direktors | 3 Seiten | OSAP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von NTL (TRIANGLE) LLC?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | British | 72139660003 | ||||||
| HIFZI, Mine Ozkan | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | England | British | 182167230001 | |||||
| MCNEIL, Roderick Gregor | Geschäftsführer | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | England | British | 267964620001 | |||||
| WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth | Geschäftsführer | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | United Kingdom | British | 248424940001 | |||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Sekretär | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | British | 47785600002 | ||||||
| CARTER, Stephen Andrew | Geschäftsführer | 22 Melville Road Barnes SW13 9RJ London | United Kingdom | British | 59445920002 | |||||
| CASTELL, William Thomas | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | England | British | 248424970001 | |||||
| DUNN, Robert Dominic | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | England | British | 179134020002 | |||||
| GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | England | British | 96956740001 | |||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| PASCU, Severina-Pompilia | Geschäftsführer | Brook Drive RG2 6UU Reading 500 United Kingdom | Switzerland | Romanian | 267797160001 | |||||
| ROBERTS, Gareth Nigel Christopher | Geschäftsführer | 20 Aspen Lodge Abbots Walk W8 5UN London | British | 145824690001 | ||||||
| ROSS, Stuart | Geschäftsführer | 15 Mckay Road SW20 0HT London | England | British | 20168110001 | |||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 140137570002 |
Hat NTL (TRIANGLE) LLC Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Confirmation deed | Erstellt am 15. Apr. 2010 Geliefert am 29. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An alternative bridge charge over shares | Erstellt am 16. Juni 2006 Geliefert am 29. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights title and interest in and to the shares and all rights moneys benefits and other property which mat accrue. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 10. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its rights title and interest in and to the shares by way of first equitable charge. By way of first fixed charge all rights moneys benefits and other property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A share charge agreement | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 29. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The charged portfolio being the shares and applicable related assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A share charge agreement | Erstellt am 24. Juni 2004 Geliefert am 30. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The charged portfolio being the shares and applicable related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0