IRISH FEEDS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | IRISH FEEDS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | NI010146 |
Gerichtsbarkeit | Nordirland |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von IRISH FEEDS LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich IRISH FEEDS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IRISH FEEDS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für IRISH FEEDS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for British Salt Limited as a person with significant control on 12. März 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Dr Ladan Iravanian am 12. März 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Dr Martin John Ashcroft am 12. März 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan Laurence Abbotts am 12. März 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of British Salt Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 21. Feb. 2018 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Dr Ladan Iravanian als Direktor am 09. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Stephen Melia als Geschäftsführer am 30. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Alan Neil Runciman am 01. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John Stephen Melia am 01. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von IRISH FEEDS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
ABBOTTS, Jonathan Laurence | Geschäftsführer | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | United Kingdom | British | Director | 150646060001 | ||||||||
ASHCROFT, Martin John, Dr | Geschäftsführer | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | England | British | Managing Director | 170663420001 | ||||||||
IRAVANIAN, Ladan, Dr | Geschäftsführer | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | United Kingdom | British | Director | 151424370002 | ||||||||
RUNCIMAN, Alan Neil | Geschäftsführer | Winnington Lane CW8 4GW Northwich Natrium House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 151762300001 | ||||||||
THOMPSON, Christopher William | Sekretär | Cranes Lane Lathom L40 5UJ Ormskirk Halfpenny Barn Lancashire United Kingdom | British | 145356080001 | ||||||||||
VAUGHAN, Mathew Gareth | Sekretär | Winnington CW8 4DT Northwich Mond House Cheshire United Kingdom | 151764290001 | |||||||||||
WARD, David Stuart | Sekretär | 2 Ingleton Close Holmes Chapel CW4 7LF Crewe England | 145356020001 | |||||||||||
BROWN, Timothy Neil | Geschäftsführer | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | England | British | Director | 129108030001 | ||||||||
CHALLINOR, David | Geschäftsführer | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | United Kingdom | British | Director | 111045130001 | ||||||||
FORSYTH, Donal A | Geschäftsführer | Ivy Lodge 17 Greenland Drive BT19 6AP Bangor | British | Director | 145356030001 | |||||||||
GENT, Alan Stanley | Geschäftsführer | 119 Station Road Marple SK6 6PA Stockport | British | Managing Director | 145356040001 | |||||||||
JONES, Robert Owen | Geschäftsführer | Somerford Close Sandbach CW11 1YL Cheshire 7 Uk United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 103532410001 | ||||||||
MELIA, John Stephen | Geschäftsführer | Winnington CW8 4DT Northwich Mond House Cheshire England | United Kingdom | British | Director | 258007910001 | ||||||||
RUNCIMAN, Alan Neil | Geschäftsführer | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | United Kingdom | British | Director | 151762300001 | ||||||||
STEVEN, David Andrew, Dr | Geschäftsführer | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | United Kingdom | British | Director | 37384700001 | ||||||||
THOMPSON, Christopher William | Geschäftsführer | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | England | British | Director | 114283730001 | ||||||||
VAUGHAN, Mathew Gareth | Geschäftsführer | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | England | British | Director | 151762730001 | ||||||||
WESTON, Leslie Derek | Geschäftsführer | Winnington CW8 4DT Northwich Mond House Cheshire | United Kingdom | British | Sales & Marketing Manager | 132971360001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei IRISH FEEDS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Salt Limited | 06. Apr. 2016 | Winnington Lane CW8 4GW Northwich Natrium House Cheshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für IRISH FEEDS LIMITED?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
11. Dez. 2016 | 20. Feb. 2018 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat IRISH FEEDS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 18. Jan. 2011 Geliefert am 25. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery...see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security accession deed | Erstellt am 18. Jan. 2011 Geliefert am 25. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery...see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 01. Jan. 2008 Geliefert am 14. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies a deed of admission supplemental to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 29TH june 2997. any sums or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present and future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 20. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies composite guarantee and debenture. 1. fixed charges. Each charging company charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by it, or in which it from time to time has an interest:. (A) by wy of legal mortgage:. (I) the property (if any) specified in part 1 of schedule 3 (details of security assets); and. (Ii) all other property (if any) at the date of this deed vested in, or charged to, each charging company (not charged by clause 1 (a) (I));. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 18. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies omnibus guarantee and set-off agreement. The company agreed that it would not assign, mortgage charge or otherwise confer upon any third party any right, title ot interest in all or to all or any of the accounts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 18. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mezzanine debenture. All security created by the chargor as a continuing security for the payment and discharge of the secured obligations. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 18. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies senior debenture. All security created by the chargor as a continuing security for the payment and discharge of the secured obligations. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 04. März 1992 Geliefert am 13. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies fixed charge on book debts all book debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the charge holder... See doc 49 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 04. März 1992 Geliefert am 13. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies second floating charge the undertaking of the property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being.. See doc 48 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 25. Mai 1988 Geliefert am 01. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Premises at the rear of corporation street and pilot street belfast. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 03. Dez. 1987 Geliefert am 07. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies allbook debts all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 26. Aug. 1987 Geliefert am 09. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 63 dock street belfast. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 21. Nov. 1979 Geliefert am 26. Nov. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The undertaking of the company and all its property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0