TIMEC 333 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TIMEC 333 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Liquidation |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | NI010410 |
Gerichtsbarkeit | Nordirland |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TIMEC 333 LIMITED?
- Bau von Geschäftsgebäuden (41201) / Bauwesen
Wo befindet sich TIMEC 333 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit A1 Boucher Business Studios Glenmachan Place BT12 6QH Belfast Antrim |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TIMEC 333 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MCALEER & RUSHE LIMITED | 29. Okt. 1974 | 29. Okt. 1974 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TIMEC 333 LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Sept. 2019 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2020 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2018 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für TIMEC 333 LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 31. März 2021 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 12. Mai 2021 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 31. März 2020 |
Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für TIMEC 333 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung bis 23. Nov. 2024 | 5 Seiten | 4.69(NI) | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung bis 23. Nov. 2023 | 5 Seiten | 4.69(NI) | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung bis 23. Nov. 2022 | 5 Seiten | 4.69(NI) | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung bis 23. Nov. 2021 | 5 Seiten | 4.69(NI) | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 17-19 Dungannon Road Cookstown Co Tyrone BT80 8TL zum Unit a1 Boucher Business Studios Glenmachan Place Belfast Antrim BT12 6QH am 03. Dez. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Vermögensübersicht | 5 Seiten | 4.21(NI) | ||||||||||
Ernennung eines Liquidators | 1 Seiten | VL1 | ||||||||||
Notification of Timec 222 Limited as a person with significant control on 30. Okt. 2020 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Mcaleer & Rushe Construction Limited as a person with significant control on 30. Okt. 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Eamon Patrick Higgins als Sekretär am 30. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Herbert Surphlis als Geschäftsführer am 30. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Francis Magee als Geschäftsführer am 30. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Seamus (James) Mcaleer als Geschäftsführer am 30. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mary Margaret Laverty als Geschäftsführer am 30. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed mcaleer & rushe LIMITED\certificate issued on 21/10/20 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Eamon Patrick Higgins als Sekretär am 24. Juli 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Stephen Higgins als Sekretär am 02. Juli 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Stephen Higgins als Geschäftsführer am 02. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TIMEC 333 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAVERTY, Eamonn Francis | Geschäftsführer | Drumcairne House 18 Drumcairne Road Stewartstown | Northern Ireland | Northern Irish | Director | 164594500001 | ||||
HIGGINS, Eamon Patrick | Sekretär | 17-19 Dungannon Road Cookstown BT80 8TL Co Tyrone | 272480100001 | |||||||
HIGGINS, James Stephen | Sekretär | 17-19 Dungannon Road Cookstown BT80 8TL Co Tyrone | Northern Irish | 116620060001 | ||||||
SCULLION, Colum | Sekretär | 63 Foxforough Mullaghmore Road BT70 1FP Dungannon Tyrone | 145381380001 | |||||||
HIGGINS, James | Geschäftsführer | 35 Maryville Park Belfast Co Antrim | Irish | Finance Director | 145381480001 | |||||
HIGGINS, James Stephen | Geschäftsführer | 17-19 Dungannon Road Cookstown BT80 8TL Co Tyrone | Northern Ireland | Irish | Accountant | 116620060002 | ||||
LAVERTY, Mary Margaret | Geschäftsführer | Drumcairne House 18 Drumcairne Road Stewartstown | Northern Ireland | Northern Irish | Director | 100394510001 | ||||
MAGEE, Martin Francis | Geschäftsführer | 23a Corrags Road Newry BT34 2NH | Northern Ireland | Northern Irish | Director | 105879500001 | ||||
MCALEER, Mary B | Geschäftsführer | 130 Drum Road Cookstown, BT80 9DN Co.Tyrone | British | Director | 145381410001 | |||||
MCALEER, Seamus (James) | Geschäftsführer | 130 Drum Road Cookstown BT80 9DN Co.Tyrone | Northern Ireland | Northern Irish | Director | 159942180001 | ||||
SCULLION, Colum | Geschäftsführer | South House Ballynorthland Park Dungannon Co Tyrone | Northern Ireland | British | Accountant | 145273430001 | ||||
SURPHLIS, Stephen Herbert | Geschäftsführer | 17-19 Dungannon Road Cookstown BT80 8TL Co Tyrone | Northern Ireland | British | Director | 116861100005 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TIMEC 333 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timec 222 Limited | 30. Okt. 2020 | Dungannon Road BT80 8TL Cookstown 17-19 Northern Ireland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mcaleer & Rushe Construction Limited | 06. Apr. 2016 | Dungannon Road BT80 8TL Cookstown 17-19 Northern Ireland | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat TIMEC 333 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 15. Dez. 2015 Geliefert am 18. Dez. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 20. Okt. 2014 Geliefert am 06. Nov. 2014 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 19. Dez. 2013 Geliefert am 23. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Escrow deed | Erstellt am 01. Feb. 2013 Geliefert am 06. Feb. 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben "Premises" means 93-94 queens road, brighton. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 05. Okt. 2005 Geliefert am 21. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben Security interest agreement - all monies. As a continuing security for the payment, performance and discharge of the secured obligations, so that the bank shall have a first priority security interest in the collateral pursuant to the law, the company:. (A) assigns, transfers and otherwise makes over to the bank or its nominee title to the collateral;. And. (B) agrees that, to the extent that the company shall not have assigned, transferred or otherwise made over to the bank or its nominee or perfected in favour of the bank or its nominee, title to any securities, the bank or its nominee shall have possession of the certificates of title thereto..... | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 26. Nov. 2004 Geliefert am 14. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies letter of set off, appropriation and combination. Letter of set-off, appropriation and combination confirming that the governor and company of the bank of ireland is entitled to hold all moneys which may stand to the credit of the commpany in account no 90-23-89 48258260. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 15. Okt. 2004 Geliefert am 01. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies deed of subordination if in contravention of this agreement mcaleer & rushe limited receives or there is paid or delivered to it ...... see doc 74 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 15. Okt. 2004 Geliefert am 01. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies deed of subordination if in contravention of this agreement or following a release of the subordinated obligations mcaleer & rushe limited receives or there is paid or delivered to it.............. See doc 73 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 26. Sept. 2003 Geliefert am 26. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies debenture the freehold property known as the 0.5 acre site at dungannon park dungannon as more particularly described in a conveyance dated 26TH september 2003 between mcshea and the company.... See doc 69 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 12. Aug. 1997 Geliefert am 14. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Mortgage/debenture a) a specific equitable charge over all future estates or interests in the property hereinafter described and over the companys estate or interest in all freehold or leasehold properties now or at any time belonging to or charged to the company other than the property hereinafter described.b) a specific charge over all book and other debts for the time being due or owing to the company but so that the company shall pay into the companys account with the bank all moneys which it may receive in respect of such debts and shall not without the prior consent in writing of the bank sell factor discount or other- wise charge or assign the same in favour of any other person or purport to do so and the company shall if called upon to do so by the bank from time to time execute legal assignments of such book debts and other debts to the bank. C) a specific charge over its goodwill and the benefit on any licences and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for the time being the companys property. D) a floating charge over the undertaking and all other pro- perty and assets present and future but so that the company shall not without the banks consent create any mortgage or charge ranking in priority to or pari passu with this charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 20. März 1997 Geliefert am 08. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Charge over shares the following shares in aldergrove airport hotel limited (a company regis- tered in northern ireland with number NI 29754). 750,000 "a" ordinary #1.00 shares 750,000 "b" ordinary #1.00 shares 1,705.259 redeemable cumulative conver- tible preference shares of #1.00 each together with the derivative assets described in the said charge over shares namely all stocks, shares, warrantes or other securities rights dividends inter- est or other property whether of a capital or income nature accruing offered issued or deriving at any time by way of dividend bonus redemption exchange purchase substitution conver- sion consolidation subdivision prefer- ence option or otherwise attributable to any of the above shares or any of the said derivative assets previously described save for the preference share dividend already accrued of #219,315. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat TIMEC 333 LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0