S.B. CHEMICALS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | S.B. CHEMICALS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | NI015925 |
Gerichtsbarkeit | Nordirland |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von S.B. CHEMICALS LIMITED?
- Herstellung von Seifen und Waschmitteln (20411) / Verarbeitendes Gewerbe
- Andere Gebäude- und Industrie-Reinigungsaktivitäten (81229) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich S.B. CHEMICALS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 17 Clarendon Road Clarendon Dock BT1 3BG Belfast |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von S.B. CHEMICALS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Feb. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für S.B. CHEMICALS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 16 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 10. Feb. 2017
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Feb. 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Feb. 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Simon Peter Bower als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 12 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 6 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von S.B. CHEMICALS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOWER, Simon Peter | Geschäftsführer | (M) Business Centre Dixons Hill Road Welham Green, North Mymms AL9 7JE Hatfield A1 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Coo / Director | 170118110001 | ||||
FRANCIS, Ringo Daisley | Geschäftsführer | Queensbury 5a Hollydell Morgans Road SG13 8BE Hertford | England | British | Director | 145824090001 | ||||
COLWELL, Anne | Sekretär | 15 Kingston Street Derby DE1 3EZ Derbyshire | 145823930001 | |||||||
COLWELL, Richard Anthony | Sekretär | 47 Mardley Hill Oaklands AL6 OTT Welwyn Herts | 145823970001 | |||||||
SELBY, Ian Robert | Sekretär | 9 Coppice Way Hedgerley SL2 3YL Buckinghamshire England | 145823960001 | |||||||
WALIA, Arvinder Singh | Sekretär | 24 Pembroke Road Northwood HA6 2HR | British | 57238690003 | ||||||
BOYLAN, Paul | Geschäftsführer | Beech Hurst Waterhouse Lane Kingswood Surrey | British | Director | 145824000001 | |||||
COLWELL, Richard Anthony | Geschäftsführer | 47 Mardley Hill Oaklands AL6 0TT Welwyn Herts | United Kingdom | British | Director | 97480080001 | ||||
FOGARTY, Colin Kenneth | Geschäftsführer | 95 Princes Street Dunstable LU6 3AS Bedfordshire | England | British | Director | 102631300002 | ||||
FRANCIS, Ringo Daisley, Mr. | Geschäftsführer | Queensbury 5a Hollydell SG13 8BE Morgans Rd Hertford | England | British | Director | 109799320001 | ||||
GRACIE, Gavin Hugh | Geschäftsführer | 57 Sutherland Crescent Chippenham SN14 6RS Wiltshire England | Uk | Zimbabwean | Accountant | 70976100003 | ||||
HALL, Brenda | Geschäftsführer | 13 Dromore Rd Hillsborough BT26 6HS Co.Down | Northern Ireland | British | Director | 143204350001 | ||||
HALL, Sean Geoffrey | Geschäftsführer | 13 Dromore Rd Hillsborough BT26 6HS Co.Down | Northern Ireland | British | Director | 144341960001 | ||||
HOLT, John Frazer | Geschäftsführer | Drumvale 11 Clontarriff Road BT28 2JD Upper Ballinderry Lisburn, Co. Antrim | Northern Ireland | British | Retired | 143510800001 | ||||
LEDWIDGE, Frank | Geschäftsführer | 15 Demense Park Holywood BT18 9NE Co Down | British | Chartered Accountant | 145824010001 | |||||
MCILROY, Thomas David | Geschäftsführer | 19 Old Galgorm Manor Ballymena BT42 1RY | Northern Ireland | British | Operations | 145824040001 | ||||
ROBINSON, Arthur Terence | Geschäftsführer | The Coach House 30a Cultra Avenue BT18 0AZ Holywood Co.Down | Northern Ireland | British | Director | 145629820001 | ||||
SELBY, Ian Robert | Geschäftsführer | 9 Coppice Way Hedgerley SL2 3YL Buckinghamshire England | England | British | Accountant | 102101830001 | ||||
SOFAT, Atul | Geschäftsführer | 104 Aldbury Drive Pinner HA5 3RG Middlesex | British | Director | 145831600001 | |||||
WALIA, Arvinder Singh | Geschäftsführer | 24 Pembroke Road Northwood HA6 2HR | England | British | Director | 57238690003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei S.B. CHEMICALS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenith Hygiene Systems Limited | 06. Apr. 2016 | A1 M Business Centre - Dixons Hill Road Welham Green, North Mymms AL9 7JE Hatfield Zenith House England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat S.B. CHEMICALS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 01. Sept. 2011 Geliefert am 09. Sept. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Altona road, altona industrial estate, lisburn registered under title number DN45993L county down. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Nov. 2008 Geliefert am 11. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage debenture. The lands and premises comprised in folios DN45993L and DN45994L co down. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 21. März 2005 Geliefert am 04. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies fixed charge.. The company hereby charges by way of fixed charge in favour of the bank as a continuing security with the payment and discharge of the secured obligations, all book and other debts and monetary claims (including, without limitation, deposits and credit balances held by third parties from time to time) now or at any time hereafter due or owing to the company .................................................................... see 402 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Feb. 2005 Geliefert am 24. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage debenture. Folios DN45993L and DN45994L co down and situate at unit 26 blaris industrial estate, altona road, lisburn. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 30. Okt. 2002 Geliefert am 11. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies floating charge. The undertaking of the company and all its property............................ See doc 105 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 30. Okt. 2002 Geliefert am 11. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies charge over book debts all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 29. Okt. 2001 Geliefert am 02. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben Floating charge - all monies a floating charge over all the undertaking of the company and all its assets whatsoever and wheresoever situate both present and future including the uncalled capital of the company. Note: by clause 4.1. the company agreed that it would..... See doc no. 101 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 05. Juli 2001 Geliefert am 09. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben Floating charge- all monies a floating charge over all the undertaking of the company and all its assets whatsoever and wheresoever situate both present and future including ..... see document 97 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 19. Feb. 1997 Geliefert am 05. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Debenture see doc 80 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 11. Nov. 1993 Geliefert am 15. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Floating charge the company as beneficial owner thereby charged by way of floating charge in favour of the chargee as a continuing security with the payment and discharge of the secured obligations all the under taking and all property and assets of the company whatsoever and wheresoever situate both present and future includin (without limitation) the uncalled capital of the company. Note:- by clause 4.1 the company agreed that it would not at any time without the prior written consent of the chargee create, extend or permit to subsist any fixed or floating security or lien (other than a lien arising by operation of law) part thereof whether in any such case ranking in priority to or pari passu with the security created pursuant to the charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 21. Feb. 1992 Geliefert am 24. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Chattels mortgage all and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof. Schedule:- 1 new 7500 gallon stainless steel limpet coil jacketed mixing vessel tank complete with variable speed heavy duty top mounted agitator together with 3" polysterine insulation. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 29. Juli 1991 Geliefert am 01. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Floating charge the undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being. Nb. The company shall not be at liberty without the prevous consent in writing of northern bank limited to create any mortgage or charge or confer any lien on its assets or any part thereof or to sell or deal with its book or other debts or securities for money otherwise than for the purpose of getting in and realising the same in the ordinary way of business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 29. Juli 1991 Geliefert am 01. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Charge over all book debts all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 28. Juni 1990 Geliefert am 28. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 37500 | |
Kurze Angaben Chattels mortgage storage tanks and ancillary equipment which is more particularly described on two copy invoices from forbes plastics limited numbered 59563 (reference 59563 (37164/re) and 59828 (reference 59528/ G38599/6/re) see attached sheets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 27. März 1990 Geliefert am 30. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 40000 | |
Kurze Angaben Floating charge all that undertaking of the company what soever and wheresoever both present and future including teh uncalled capital of the company for the time being (if any) the company shall not be at liberty to create without the privious consent of the chargees and mortgage charge or lien on any of its assets ranking in priority hereto or pari passu herewith. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 11. Aug. 1983 Geliefert am 22. Aug. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Debenture see doc 11 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0