MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED

MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer NI016891
    GerichtsbarkeitNordirland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED?

    • Herstellung von Metallkonstruktionen und Teilen von Konstruktionen (25110) / Verarbeitendes Gewerbe
    • Herstellung von Türen und Fenstern aus Metall (25120) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Pricewaterhousecoopers Llp Waterfront Plaza
    8 Laganbank Road
    BT1 3LR Belfast
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MCMULLEN GLASS LIMITED26. Aug. 198326. Aug. 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Administrators bis 03. Dez. 2018

    18 Seiten2.24B(NI)

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    18 Seiten2.35B(NI)

    Fortschrittsbericht des Administrators bis 04. Juni 2018

    12 Seiten2.24B(NI)

    Fortschrittsbericht des Administrators bis 04. Dez. 2017

    13 Seiten2.24B(NI)

    Mitteilung über die Verlängerung des Verwaltungszeitraums

    1 Seiten2.31B(NI)

    Fortschrittsbericht des Administrators bis 04. Juni 2017

    12 Seiten2.24B(NI)

    Fortschrittsbericht des Administrators bis 04. Dez. 2016

    13 Seiten2.24B(NI)

    Mitteilung über die Verlängerung des Verwaltungszeitraums

    2 Seiten2.31B(NI)

    Fortschrittsbericht des Administrators bis 04. Juni 2016

    15 Seiten2.24B(NI)

    Fortschrittsbericht des Administrators bis 04. Dez. 2015

    13 Seiten2.24B(NI)

    Mitteilung über die Verlängerung des Verwaltungszeitraums

    1 Seiten2.31B(NI)

    Fortschrittsbericht des Administrators bis 04. Juni 2015

    15 Seiten2.24B(NI)

    Fortschrittsbericht des Administrators bis 04. Dez. 2014

    8 Seiten2.24B(NI)

    Fortschrittsbericht des Administrators bis 04. Juni 2014

    9 Seiten2.24B(NI)

    Mitteilung über die Verlängerung des Verwaltungszeitraums

    1 Seiten2.31B(NI)

    Mitteilung über das Ergebnis der Gläubigerversammlung

    28 Seiten2.23B(NI)

    Fortschrittsbericht des Administrators bis 04. Dez. 2013

    9 Seiten2.24B(NI)

    Mitteilung über die Verlängerung des Verwaltungszeitraums

    1 Seiten2.31B(NI)

    Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Administrators

    1 Seiten2.40B(NI)

    Mitteilung über den Rücktritt des Administrators

    11 Seiten2.39B(NI)

    Fortschrittsbericht des Administrators bis 04. Juni 2013

    9 Seiten2.24B(NI)

    Erklärung des Vorschlags des Administrators

    27 Seiten2.17B(NI)

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 66 Lurgan Road Moira Craigavon Co Armagh BT67 0LX* am 10. Dez. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Administrators

    1 Seiten2.12B(NI)

    Wer sind die Geschäftsführer von MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PENTLAND, John David
    63 Kings Road
    Belfast
    BT5 7BT
    Sekretär
    63 Kings Road
    Belfast
    BT5 7BT
    British129637620001
    MCMULLEN, Edward Russell
    Greenmount
    205 Bangor Road
    BT18 0JG Holywood
    Co Down
    Geschäftsführer
    Greenmount
    205 Bangor Road
    BT18 0JG Holywood
    Co Down
    Northern IrelandBritishDirector145717920001
    MILLS, Ronald Douglas
    6 Shanecracken Road
    Markethill
    BT60 1TS Co Armagh
    Geschäftsführer
    6 Shanecracken Road
    Markethill
    BT60 1TS Co Armagh
    Northern IrelandBritishTechnical Engineer145717890001
    O'ROURKE, John Anthony
    18 Baronscourt Heights
    Carryduff
    BT8 Belfast
    Geschäftsführer
    18 Baronscourt Heights
    Carryduff
    BT8 Belfast
    Northern IrelandBritishQuantity Surveyor145717880001
    PENTLAND, John David
    63 Kings Road
    Belfast
    BT5 7BT Co Antrim
    Geschäftsführer
    63 Kings Road
    Belfast
    BT5 7BT Co Antrim
    Northern IrelandBritishChartered Accountant129637620001
    BAILIE, Thomas Holden
    12 Lambert Rise
    Dunlady Road
    BT16 0LQ Dundonald
    Belfast
    Geschäftsführer
    12 Lambert Rise
    Dunlady Road
    BT16 0LQ Dundonald
    Belfast
    BritishCertified Accountant145717930001
    GIBSON, Patrick Coulter Maxwell
    15 Finaghy Park North
    Finaghy
    BT10 Belfast
    Geschäftsführer
    15 Finaghy Park North
    Finaghy
    BT10 Belfast
    BritishDirector145717870001

    Hat MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 04. Apr. 2008
    Geliefert am 08. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies debenture. Grants and demises unto the bank all freehold estates and interests in all freehold properties now or hereafter belonging to it together with the premises and the fixtures on and in them.
    Berechtigte Personen
    • Ulster Bank Ireland Limited
    • Ulster Bank Limited
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 13. Sept. 2000
    Geliefert am 19. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Floating charge. The undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being. N.B. the company shall not be at liberty without the previous consent in writing of northern bank limited to create any mortgage or charge or confer any lien on its assets or any part thereof or to sell or deal with its book or other debts or securities for money otherwise than for the purpose of getting in and realising the same in the ordinary way of business.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank LTD
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 13. Sept. 2000
    Geliefert am 19. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Charge over all book debts. All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank LTD
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2000
    Mortgage or charge
    Erstellt am 03. Okt. 1996
    Geliefert am 22. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Charge on book debts all monies covenanted to be paid by the company and all present and future debts of the company and the proceeds of the same and all debts as set out in the schedule to the charge and the proceeds of same and the monies at all times standing to the credit of the specific bank account of the company.
    Berechtigte Personen
    • Icc Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 03. Okt. 1996
    Geliefert am 22. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. First floating charge all the companys undertaking and assets wheresoever and whatsoever both present and future including its uncalled capital for the time being and goodwill.
    Berechtigte Personen
    • Icc Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (402 NI)
    • 06. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 03. Okt. 1996
    Geliefert am 22. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    200000
    Kurze Angaben
    Assignment of life policy policy of assurance on the life of edward russell mcmullen granted by norwich union dated 19/7/91 being policy no. Ub 62000205 in the sum of #200,000 (two hundred thousand pounds sterling) and all monies assured or to become payable by or under the said policy.
    Berechtigte Personen
    • Icc Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 03. Okt. 1996
    Geliefert am 22. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. First specific charge all its freehold and leasehold property and assets whatsoever and wheresoever both present and future including the lands, hereditaments and premises at 66 lurgan road, moira, carigavon contained in folio no 37767 county down and dn 24818 county down together with all fixtures and fittings therein, its industrial plant whether fixed or moveable, computers, office and other equipment both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Icc Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 22. Okt. 1993
    Geliefert am 27. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Assignation all that the companys right title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the policies of insurance described in the schedule below and the right to exercise all powers and remedies for cancelling and/or enforcing the same schedule:- placing broker nelson hurst & marsh limited policy no. 63551458 date 03/09/03.
    Berechtigte Personen
    • Roy Scot Trust PLC
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 07. Okt. 1993
    Geliefert am 12. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Mortgage the lands comprised in folio nos 37767 and dn 24818 county down, held in fee simple, together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank LTD
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 09. Juli 1986
    Geliefert am 11. Juli 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Charge over all book debts all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank LTD
    Transaktionen
    • 11. Juli 1986Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 09. Juli 1986
    Geliefert am 11. Juli 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Floating charge the undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being. Nb. The company shall not be at liberty without the previous consent in writing of northern bank limited to create any mortgage or charge or confer any lien on its assets or any part thereof or to sell or deal with its book or other debts or securities for money other- wise than for the purpose of getting in and realising the same in the ordinary way of business.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank LTD
    Transaktionen
    • 11. Juli 1986Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 30. Apr. 1985
    Geliefert am 10. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Mortgage the companys right title estate and interest in property situate at 13 logan drive, lurgan in the county of armagh and all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank LTD
    Transaktionen
    • 10. Mai 1985Registrierung einer Belastung (402 NI)

    Hat MCMULLEN ARCHITECTURAL SYSTEMS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. Dez. 2012Beginn der Verwaltung
    03. Dez. 2018Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Cave
    Waterfront Plaza 8 Laganbank Road
    BT1 3LR Belfast
    Praktiker
    Waterfront Plaza 8 Laganbank Road
    BT1 3LR Belfast
    Paul Rooney
    Waterfront Plaza 8 Laganbank Road
    BT1 3LR Belfast
    County Antrim
    Praktiker
    Waterfront Plaza 8 Laganbank Road
    BT1 3LR Belfast
    County Antrim
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0