DUNBIA (NORTHERN IRELAND)

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDUNBIA (NORTHERN IRELAND)
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer NI016970
    GerichtsbarkeitNordirland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    • Schlachtung, Verarbeitung und Konservierung von Fleisch (10110) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DUNGANNON MEATS26. März 199826. März 1998
    DUNGANNON MEATS LIMITED05. Okt. 198305. Okt. 1983

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2019 bis 30. Juni 2020

    1 SeitenAA01

    Eintragung der Belastung NI0169700025, erstellt am 29. Juli 2020

    75 SeitenMR01

    Beendigung der Bestellung von James George Dobson als Geschäftsführer am 29. Juli 2020

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Matthew Samuel Dobson als Geschäftsführer am 29. Juli 2020

    1 SeitenTM01

    Eintragung der Belastung NI0169700024, erstellt am 29. Juli 2020

    42 SeitenMR01

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Jan. 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Notification of Dunbia (Uk) as a person with significant control on 29. Nov. 2019

    4 SeitenPSC02

    Cessation of Dunbia Limited as a person with significant control on 29. Nov. 2019

    3 SeitenPSC07

    legacy

    2 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 17. Dez. 2019

    • Kapital: GBP 1.00
    4 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12

    Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse

    2 SeitenSH08

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Dez. 2018

    31 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. März 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    29 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Sean Breen als Sekretär am 27. Feb. 2018

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Apr. 2017

    28 SeitenAA

    Eintragung der Belastung NI0169700023, erstellt am 18. Dez. 2017

    25 SeitenMR01

    Wer sind die Geschäftsführer von DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BREEN, Sean
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Geschäftsführer
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrish239253300004
    BROWNE, Niall
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Geschäftsführer
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrish223137440001
    QUEALLY, Michael
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Geschäftsführer
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrish239899450002
    BREEN, Sean
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Sekretär
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    239278860001
    DOBSON, James
    98 Old English Road
    Dungannon
    Co Tyrone
    Sekretär
    98 Old English Road
    Dungannon
    Co Tyrone
    145673530001
    PROCTOR, John Joseph
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Sekretär
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    British145673580002
    CULLEN, Paul Damien
    19 Ravensdale
    Manse Road
    BT36 6FA Carnmoney
    Co Antrim
    Geschäftsführer
    19 Ravensdale
    Manse Road
    BT36 6FA Carnmoney
    Co Antrim
    Northern IrelandNorthern Irish143854490001
    DEMPSEY, Liam Joseph
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Geschäftsführer
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    United KingdomBritish130963600004
    DOBSON, James George
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Geschäftsführer
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish60391230001
    DOBSON, Matthew Samuel
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Geschäftsführer
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish216974160001
    DOBSON, Robert John
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Geschäftsführer
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish60768390001
    DORAN, Michael
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Geschäftsführer
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish145673620002
    FARRELL, David Allan Raymond
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Geschäftsführer
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish145673660002
    GRAHAM, Edison Wilson
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Geschäftsführer
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandIrish145110860001
    HANGER, Trevor
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Geschäftsführer
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    UkBritish163090380001
    MCKEAVNEY, Robert Edward
    25 Coachmans Way
    Culcavy
    BT26 6HQ Hillsborough
    Co Down
    Geschäftsführer
    25 Coachmans Way
    Culcavy
    BT26 6HQ Hillsborough
    Co Down
    United KingdomBritish60391320001
    MCKEOWN, Alan
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Geschäftsführer
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish145673610002
    MILLIGAN, Gordon John
    10 Grangee Road
    Carrowdore
    BT22 2JB Newtownards
    Geschäftsführer
    10 Grangee Road
    Carrowdore
    BT22 2JB Newtownards
    Northern IrelandBritish145673640001
    POTTS, Colin Edwin
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Geschäftsführer
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    United KingdomBritish125726160003
    PROCTOR, John Joseph
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Geschäftsführer
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish145673580002
    SWANN, Kenneth Thomas
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Geschäftsführer
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish145673590002
    TWEEDIE, Henry Campbell
    Stonethorpe Cottage
    116 Belfast Road
    BT23 4TY Newtownards
    Co Down
    Geschäftsführer
    Stonethorpe Cottage
    116 Belfast Road
    BT23 4TY Newtownards
    Co Down
    Northern IrelandBritish48171740001
    YOUNG, Jonathan
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Geschäftsführer
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish148532740002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Castle Street
    EX4 3LG Exeter
    Michael House
    Devon
    England
    29. Nov. 2019
    Castle Street
    EX4 3LG Exeter
    Michael House
    Devon
    England
    Nein
    RechtsformUnlimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03382084
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Dunbia Limited
    Granville Road
    BT70 1NJ Dungannon
    Unit 9
    Northern Ireland
    06. Apr. 2016
    Granville Road
    BT70 1NJ Dungannon
    Unit 9
    Northern Ireland
    Ja
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandNorthern Ireland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortUnited Kingdom Companies House
    RegistrierungsnummerNi059523
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat DUNBIA (NORTHERN IRELAND) Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 29. Juli 2020
    Geliefert am 11. Aug. 2020
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Factory facilities and offices being land and buildings known as site a, granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone and registered with freehold number TY62002 county tyrone and leasehold folio numbers TY3069L, TY1647L, TY4950L, TY10143L, TY11270L and TY65783L all county tyrone and the retail packing facility being land and buildings known as site b, granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone and registered with leasehold folio number TY13162L county tyrone, specific intellectual property as outlined in the instrument.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2020Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 29. Juli 2020
    Geliefert am 10. Aug. 2020
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2020Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Dez. 2017
    Geliefert am 22. Dez. 2017
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The "Lender")
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Okt. 2017
    Geliefert am 18. Okt. 2017
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Real property, shares and investments and specified intellectual property, for more details please refer to the instrument.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Okt. 2017
    Geliefert am 18. Okt. 2017
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Non-vesting debts. For more details please refer to the instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Okt. 2017
    Geliefert am 18. Okt. 2017
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Real property, shares and investments, specific intellectual property, relevant contracts, for more details please refer to the instrument.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 24. Juli 2014
    Geliefert am 05. Aug. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Land and buildings known as granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone being: TY3069L county tyrone, TY1647L county tyrone, TY4950L county tyrone, TY10143L county tyrone, TY11270L county tyrone, TY65783L county tyrone and TY62002 county tyrone.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 25. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 27. Feb. 2014
    Geliefert am 12. März 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Land and buildings known as granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone being: TY3069L county tyrone, TY1647L county tyrone, TY4950L county tyrone, TY10143L county tyrone, TY11270L county tyrone, TY65783L county tyrone and TY62002 county tyrone together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon, all easements, rights and agreements and the benefit of all covenants given in respect thereof.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 12. März 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 25. Apr. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 16. Dez. 2011
    Geliefert am 23. Dez. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Apr. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 19. Okt. 2010
    Geliefert am 03. Nov. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (A) granted and demised unto the bank all of the property described in the schedule hereto to hold so much of same as is of freehold tenure unto the bank...see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 03. Nov. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Apr. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 18. Okt. 2010
    Geliefert am 18. Okt. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge (I) all purchased debts being any book debts as defined in the agreement, purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement...see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 18. Dez. 2008
    Geliefert am 23. Dez. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    £1,7000,000.00 mortage. The lands comprised in folios 6195 co tyrone, TY9521L co tyrone, TY10143L co tyrone, TY11270L co tyrone and 13070L co antrim.
    Berechtigte Personen
    • Premier Pension Trustees Limited
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (402R NI)
    • 09. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 24. Aug. 2007
    Geliefert am 31. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies company mortgage and charge. All lands comprised in folio TY65783L co tyrone.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank Limited
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (402 NI)
    • 20. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 02. Dez. 2002
    Geliefert am 09. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies mortgage lands comprised in folio TY13162L county tyrone........................... See doc 73 for further details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank LTD
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (402 NI)
    • 20. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 18. Juli 2001
    Geliefert am 23. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    Mortgage - all monies the lands comprised in folio AN12756L co antrim together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank LTD
    Transaktionen
    • 23. Juli 2001Registrierung einer Belastung (402 NI)
    • 20. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 11. Mai 1989
    Geliefert am 16. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and premises in folio nos ty 3069L and ty 4950L and all machinery utensils chattels.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank Limited
    Transaktionen
    • 16. Mai 1989
    • 20. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 09. Feb. 1988
    Geliefert am 10. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Pieces or parcels of ground at dungannon park dungannon county tyrone all machinery utensils chattels.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank Limited
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1988
    • 20. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 17. Dez. 1987
    Geliefert am 30. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Portion of ground in the townland of cormullagh folio ty 1647L county tyrone all machinery utensils chattels.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank Limited
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1987
    • 20. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 27. Okt. 1986
    Geliefert am 27. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Chattels being one jnf power pack serial number FPP6650, fifteen searl coils serial numbers 2 x lci 614/8 x LC5 1014/ 1 x LC3 814/ 3 x SH4 6/6 1 x kgl 180, one baltimore evaporator condensor serial number BC1528.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1986
    • 04. Okt. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 24. Okt. 1986
    Geliefert am 27. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Chattels being one new toyota forklift serial number 10277, one harmonica roller serial number HRC7, one vac pack bags table serial number vpbt 1500/750, ten bag holders, one strip curtain, one breaking bar.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1986
    • 04. Okt. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 24. Okt. 1986
    Geliefert am 27. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Chattels being one atlas copco GA230 compressor one glass fibre tank capacity 3. 8490 litres serial no. GFT38490, one beaumont hot water generator serial no. 5060HZ, one beef hidepuller serial no. 151F0201.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1986
    • 04. Okt. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 24. Okt. 1986
    Geliefert am 27. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All chattels being one 4150CTN/el/fb/ba overhead scale, one 4150CTN/ll/r/kb/bj overhead scale.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1986
    • 04. Okt. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 24. Okt. 1986
    Geliefert am 27. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All chattels being bleed rail serial number BR1 rails in slaughterhall marshalling area 8 rails in sides chills quarters chill boning room and detained room for details of further chattels charged please refer to the form.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1986
    • 04. Okt. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over all book debts
    Erstellt am 28. Nov. 1983
    Geliefert am 30. Nov. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All book and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank Limited
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1983
    • 20. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge
    Erstellt am 28. Nov. 1983
    Geliefert am 30. Nov. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Northern Bank Limited
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1983
    • 20. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0