DUNBIA (NORTHERN IRELAND)
Überblick
| Unternehmensname | DUNBIA (NORTHERN IRELAND) |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | NI016970 |
| Gerichtsbarkeit | Nordirland |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?
- Schlachtung, Verarbeitung und Konservierung von Fleisch (10110) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DUNGANNON MEATS | 26. März 1998 | 26. März 1998 |
| DUNGANNON MEATS LIMITED | 05. Okt. 1983 | 05. Okt. 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2019 bis 30. Juni 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung NI0169700025, erstellt am 29. Juli 2020 | 75 Seiten | MR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James George Dobson als Geschäftsführer am 29. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Samuel Dobson als Geschäftsführer am 29. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung NI0169700024, erstellt am 29. Juli 2020 | 42 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Jan. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Dunbia (Uk) as a person with significant control on 29. Nov. 2019 | 4 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Dunbia Limited as a person with significant control on 29. Nov. 2019 | 3 Seiten | PSC07 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 17. Dez. 2019
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse | 2 Seiten | SH08 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Dez. 2018 | 31 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 29 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sean Breen als Sekretär am 27. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Apr. 2017 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung NI0169700023, erstellt am 18. Dez. 2017 | 25 Seiten | MR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREEN, Sean | Geschäftsführer | Grannagh Waterford C/O Dawn Meats Ireland | Ireland | Irish | 239253300004 | |||||
| BROWNE, Niall | Geschäftsführer | Grannagh Waterford C/O Dawn Meats Ireland | Ireland | Irish | 223137440001 | |||||
| QUEALLY, Michael | Geschäftsführer | Grannagh Waterford C/O Dawn Meats Ireland | Ireland | Irish | 239899450002 | |||||
| BREEN, Sean | Sekretär | Grannagh Waterford C/O Dawn Meats Ireland | 239278860001 | |||||||
| DOBSON, James | Sekretär | 98 Old English Road Dungannon Co Tyrone | 145673530001 | |||||||
| PROCTOR, John Joseph | Sekretär | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | British | 145673580002 | ||||||
| CULLEN, Paul Damien | Geschäftsführer | 19 Ravensdale Manse Road BT36 6FA Carnmoney Co Antrim | Northern Ireland | Northern Irish | 143854490001 | |||||
| DEMPSEY, Liam Joseph | Geschäftsführer | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | United Kingdom | British | 130963600004 | |||||
| DOBSON, James George | Geschäftsführer | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | 60391230001 | |||||
| DOBSON, Matthew Samuel | Geschäftsführer | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | 216974160001 | |||||
| DOBSON, Robert John | Geschäftsführer | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | 60768390001 | |||||
| DORAN, Michael | Geschäftsführer | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | 145673620002 | |||||
| FARRELL, David Allan Raymond | Geschäftsführer | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | 145673660002 | |||||
| GRAHAM, Edison Wilson | Geschäftsführer | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | Irish | 145110860001 | |||||
| HANGER, Trevor | Geschäftsführer | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Uk | British | 163090380001 | |||||
| MCKEAVNEY, Robert Edward | Geschäftsführer | 25 Coachmans Way Culcavy BT26 6HQ Hillsborough Co Down | United Kingdom | British | 60391320001 | |||||
| MCKEOWN, Alan | Geschäftsführer | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | 145673610002 | |||||
| MILLIGAN, Gordon John | Geschäftsführer | 10 Grangee Road Carrowdore BT22 2JB Newtownards | Northern Ireland | British | 145673640001 | |||||
| POTTS, Colin Edwin | Geschäftsführer | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | United Kingdom | British | 125726160003 | |||||
| PROCTOR, John Joseph | Geschäftsführer | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | 145673580002 | |||||
| SWANN, Kenneth Thomas | Geschäftsführer | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | 145673590002 | |||||
| TWEEDIE, Henry Campbell | Geschäftsführer | Stonethorpe Cottage 116 Belfast Road BT23 4TY Newtownards Co Down | Northern Ireland | British | 48171740001 | |||||
| YOUNG, Jonathan | Geschäftsführer | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | 148532740002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunbia (Uk) | 29. Nov. 2019 | Castle Street EX4 3LG Exeter Michael House Devon England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Dunbia Limited | 06. Apr. 2016 | Granville Road BT70 1NJ Dungannon Unit 9 Northern Ireland | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DUNBIA (NORTHERN IRELAND) Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 29. Juli 2020 Geliefert am 11. Aug. 2020 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Factory facilities and offices being land and buildings known as site a, granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone and registered with freehold number TY62002 county tyrone and leasehold folio numbers TY3069L, TY1647L, TY4950L, TY10143L, TY11270L and TY65783L all county tyrone and the retail packing facility being land and buildings known as site b, granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone and registered with leasehold folio number TY13162L county tyrone, specific intellectual property as outlined in the instrument. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 29. Juli 2020 Geliefert am 10. Aug. 2020 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 18. Dez. 2017 Geliefert am 22. Dez. 2017 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Okt. 2017 Geliefert am 18. Okt. 2017 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Real property, shares and investments and specified intellectual property, for more details please refer to the instrument. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Okt. 2017 Geliefert am 18. Okt. 2017 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Non-vesting debts. For more details please refer to the instrument. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Okt. 2017 Geliefert am 18. Okt. 2017 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Real property, shares and investments, specific intellectual property, relevant contracts, for more details please refer to the instrument. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 24. Juli 2014 Geliefert am 05. Aug. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Land and buildings known as granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone being: TY3069L county tyrone, TY1647L county tyrone, TY4950L county tyrone, TY10143L county tyrone, TY11270L county tyrone, TY65783L county tyrone and TY62002 county tyrone. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 27. Feb. 2014 Geliefert am 12. März 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Land and buildings known as granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone being: TY3069L county tyrone, TY1647L county tyrone, TY4950L county tyrone, TY10143L county tyrone, TY11270L county tyrone, TY65783L county tyrone and TY62002 county tyrone together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon, all easements, rights and agreements and the benefit of all covenants given in respect thereof.. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Dez. 2011 Geliefert am 23. Dez. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 19. Okt. 2010 Geliefert am 03. Nov. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (A) granted and demised unto the bank all of the property described in the schedule hereto to hold so much of same as is of freehold tenure unto the bank...see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 18. Okt. 2010 Geliefert am 18. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge (I) all purchased debts being any book debts as defined in the agreement, purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement...see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage or charge | Erstellt am 18. Dez. 2008 Geliefert am 23. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben £1,7000,000.00 mortage. The lands comprised in folios 6195 co tyrone, TY9521L co tyrone, TY10143L co tyrone, TY11270L co tyrone and 13070L co antrim. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage or charge | Erstellt am 24. Aug. 2007 Geliefert am 31. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies company mortgage and charge. All lands comprised in folio TY65783L co tyrone. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage or charge | Erstellt am 02. Dez. 2002 Geliefert am 09. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies mortgage lands comprised in folio TY13162L county tyrone........................... See doc 73 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage or charge | Erstellt am 18. Juli 2001 Geliefert am 23. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben Mortgage - all monies the lands comprised in folio AN12756L co antrim together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 11. Mai 1989 Geliefert am 16. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and premises in folio nos ty 3069L and ty 4950L and all machinery utensils chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 09. Feb. 1988 Geliefert am 10. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Pieces or parcels of ground at dungannon park dungannon county tyrone all machinery utensils chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 17. Dez. 1987 Geliefert am 30. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Portion of ground in the townland of cormullagh folio ty 1647L county tyrone all machinery utensils chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 27. Okt. 1986 Geliefert am 27. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Chattels being one jnf power pack serial number FPP6650, fifteen searl coils serial numbers 2 x lci 614/8 x LC5 1014/ 1 x LC3 814/ 3 x SH4 6/6 1 x kgl 180, one baltimore evaporator condensor serial number BC1528. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 24. Okt. 1986 Geliefert am 27. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Chattels being one new toyota forklift serial number 10277, one harmonica roller serial number HRC7, one vac pack bags table serial number vpbt 1500/750, ten bag holders, one strip curtain, one breaking bar. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 24. Okt. 1986 Geliefert am 27. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Chattels being one atlas copco GA230 compressor one glass fibre tank capacity 3. 8490 litres serial no. GFT38490, one beaumont hot water generator serial no. 5060HZ, one beef hidepuller serial no. 151F0201. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 24. Okt. 1986 Geliefert am 27. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All chattels being one 4150CTN/el/fb/ba overhead scale, one 4150CTN/ll/r/kb/bj overhead scale. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 24. Okt. 1986 Geliefert am 27. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All chattels being bleed rail serial number BR1 rails in slaughterhall marshalling area 8 rails in sides chills quarters chill boning room and detained room for details of further chattels charged please refer to the form. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over all book debts | Erstellt am 28. Nov. 1983 Geliefert am 30. Nov. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All book and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 28. Nov. 1983 Geliefert am 30. Nov. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0