MOURNE COUNTRY MEATS LIMITED

MOURNE COUNTRY MEATS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMOURNE COUNTRY MEATS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer NI017064
    GerichtsbarkeitNordirland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MOURNE COUNTRY MEATS LIMITED?

    • (1511) /

    Wo befindet sich MOURNE COUNTRY MEATS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3 Wellington Park
    Malone Road
    BT9 6DJ Belfast
    Northern Ireland
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOURNE COUNTRY MEATS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2009

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MOURNE COUNTRY MEATS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MOURNE COUNTRY MEATS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Änderung der Details des Direktors für Gerard Young am 01. Sept. 2014

    3 SeitenCH01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung bis 03. Juli 2014

    7 Seiten4.69(NI)

    Rückgabedatum der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.73(NI)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung bis 10. März 2014

    6 Seiten4.69(NI)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung bis 10. März 2013

    6 Seiten4.69(NI)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung bis 10. März 2012

    6 Seiten4.69(NI)

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , 24a Rampart Road, Greenbank Industrial Estate, Newry, Co Down, BT34 2QU am 18. März 2011

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht

    10 Seiten4.21(NI)

    legacy

    2 Seiten558(NI)

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    insolvency

    Sonderbeschluss zur Abwicklung

    LRESC(NI)

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Dez. 2010

    Kapitalaufstellung am 06. Dez. 2010

    • Kapital: GBP 1,230,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Michelle Toner als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von John Pannell als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2009

    38 SeitenAA

    Ernennung von Gerard Young als Direktor

    4 SeitenAP01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Ernennung von Mr John Pannell als Direktor

    2 SeitenAP01

    legacy

    7 SeitenMG01

    Beschlüsse

    Resolutions
    40 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Conflict of interests 18/02/2010
    RES13
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    2 SeitenCC04

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 18. Feb. 2010

    • Kapital: GBP 1,230,000
    6 SeitenSH01

    Ernennung von Nigel S Mansley als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Ernennung von Michael Mcloughlin als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Bernarde Powell als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von MOURNE COUNTRY MEATS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MANSLEY, Nigel S
    Ballyholme Road
    BT20 5JL Bangor
    33
    County Down
    Sekretär
    Ballyholme Road
    BT20 5JL Bangor
    33
    County Down
    British149303980001
    MCLOUGHLIN, Michael
    Rampart Road
    Greenbank Industrial Estate
    BT34 2QU Newry
    24a
    County Down
    Geschäftsführer
    Rampart Road
    Greenbank Industrial Estate
    BT34 2QU Newry
    24a
    County Down
    N. IrelandIrish144133400001
    POWELL, Brian
    Wellington Park
    Malone Road
    BT9 6DJ Belfast
    3
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    Wellington Park
    Malone Road
    BT9 6DJ Belfast
    3
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrish144514000001
    POWELL, Laurence
    Wellington Park
    Malone Road
    BT9 6DJ Belfast
    3
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    Wellington Park
    Malone Road
    BT9 6DJ Belfast
    3
    Northern Ireland
    N IrelandIrish144513980002
    YOUNG, Gerard
    Ballyraggan
    Rathvilly
    Carlow
    Ireland
    Geschäftsführer
    Ballyraggan
    Rathvilly
    Carlow
    Ireland
    IrelandIrish149906950002
    POWELL, Bernarde
    24a Rampart Road
    Greenbank Industrial Estate
    BT34 2QU Newry
    Co Down
    Sekretär
    24a Rampart Road
    Greenbank Industrial Estate
    BT34 2QU Newry
    Co Down
    Irish144513990001
    DUFFY, Tom
    1 St Fintan's Crescent
    Sutton
    Dublin 13
    Ireland
    Geschäftsführer
    1 St Fintan's Crescent
    Sutton
    Dublin 13
    Ireland
    Irish144514020001
    PANNELL, John Roderick William
    Holly Park Road
    Killinchy
    BT23 6SN Newtownards
    37
    County Down
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    Holly Park Road
    Killinchy
    BT23 6SN Newtownards
    37
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish111544070001
    POWELL, Bernarde
    24a Rampart Road
    Greenbank Industrial Estate
    BT34 2QU Newry
    Co Down
    Geschäftsführer
    24a Rampart Road
    Greenbank Industrial Estate
    BT34 2QU Newry
    Co Down
    Northern IrelandIrish145247000002
    TONER, Michelle
    75 Balmoral Avenue
    Belfast
    BT9 6NY
    Geschäftsführer
    75 Balmoral Avenue
    Belfast
    BT9 6NY
    Northern IrelandN Irish144514010001

    Hat MOURNE COUNTRY MEATS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Floating charge
    Erstellt am 18. Feb. 2010
    Geliefert am 03. März 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1. creation of security. Pursuant to the charge, the company as beneficial owner as continuing security for the payment, performance and discharge of the secured liabilities charges to the lender, by way of floating charge, the whole of the company's property and assets (including, without limitation, uncalled capital) which is or may from time to time (during the security period) be comprised in the property and undertaking of the company...see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • International Food Services Limited
    Transaktionen
    • 03. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Charge by way of debenture
    Erstellt am 04. Feb. 2010
    Geliefert am 09. Feb. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all the freehold and leasehold property of the company now vested in it whether or not registered at hm land registry together with all buildings fixtures including trade fixtures and fixed plant and machinery from time to time thereon...see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Invoice Finance LTD
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 30. Apr. 2009
    Geliefert am 07. Mai 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies debenture. The company, as beneficial owner and as security for the payment and discharge of the debt: charges, demises, assigns, grants and conveys by way of legal mortgage all freehold and leasehold land now vested in the company together with all buildings fixtures, fittings and fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Invest Northern Ireland
    Transaktionen
    • 07. Mai 2009Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 07. März 2007
    Geliefert am 09. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies floating charge. By way of first floating charge, all the company's property, assets, rights and undertaking both present and future including without limitation, its uncalled capital and goodwill.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transaktionen
    • 09. März 2007Registrierung einer Belastung (402 NI)
    • 12. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 04. Apr. 2005
    Geliefert am 14. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies floating charge. The company charges by way of floating charge in favour of invest NI as a continuing security with the payment and discharge of the secured obligations as defined in the floating charge.... See 402 for further details.
    Berechtigte Personen
    • Invest Northern Ireland
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 04. Apr. 2005
    Geliefert am 14. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies mortgage. Unit 24A rampart road, greenbank industrial estate, newry BT34 2QU.
    Berechtigte Personen
    • Invest Northern Ireland
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 15. Mai 2002
    Geliefert am 24. Mai 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies mortgage debenture. The assets of the company designated hereunder:- (b) by way of fixed equitable charge charges all estates or interest in any freehold and leasehold property (except the legally mortgaged property) now and at any time during the continuance of this security .......................... see doc 73 for further details.
    Berechtigte Personen
    • Belfast
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 2002Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 12. Dez. 2001
    Geliefert am 14. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    Chattel mortgage - Œ30,000 and all other monies plant & equipment as per schedule ..... see attached schedule on doc. No. 71. for further details.
    Berechtigte Personen
    • Belfast
    • Emerging Business
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 07. Sept. 2001
    Geliefert am 20. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    Legal charge - Œ160,000 plus interest and charges misellaneous tenderising, slicing, mincing, injecting and processing equipment used in the production of ham/bacon joints as detailed in the attached schedule.
    Berechtigte Personen
    • Niib Group Limited
    • Bangor
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 30. Juli 2001
    Geliefert am 01. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    80000
    Kurze Angaben
    Legal charge 1 no. 3M revobank travelling multi- purpose cooker to include steam boiler and tunnel chilling system per double d food engineering invoice no.31360/ Works order 21-29032. 1 no. Air inlet dust to burner per invoice no.31966 (Double d engineering) /workds order 21/29032. 1 no. Stainless steel bifurcated fan per invoice no.31966 (Double d engineering)/works order 21/29032.
    Berechtigte Personen
    • Niib Group Limited
    • Bangor
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 13. Nov. 1997
    Geliefert am 18. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Chattels mortgage all and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof schedule:- 1 used grote 522 slicer applicator, serial no 1055692.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust LTD
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 29. Aug. 1996
    Geliefert am 11. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Chattels mortgage all and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof schedule: one new tiromat compact 270 vacuum pckaging/gas-flushing thermo- former with ancillary equipment, serial number 7771411047.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust LTD
    Transaktionen
    • 11. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 12. Juni 1995
    Geliefert am 13. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Chattels mortgage see doc 47 for details.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust LTD
    Transaktionen
    • 13. Juni 1995Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 04. Apr. 1995
    Geliefert am 05. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Chattels mortgage see doc 45 for details.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust LTD
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 09. Dez. 1992
    Geliefert am 10. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Chattels mortgage all and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof one new stainless steel double trolly vsd/reich cooker serial no. 34892/V.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust LTD
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (402 NI)
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 01. Feb. 1990
    Geliefert am 07. Feb. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Chattels mortgage all and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof. 1 new aic waterproof stainless steel floor scale including interface 1 new electric pallet truck 2 new light/heavy scales 1 new brine make tank 6 new stainless stees curing tanks 2 new grav automatic meat slicers 2 new waterproof aic bench scale electronic 1 new multineedle injector serial no 22389 12 new aluminium pallets 3 new computers serial no. 20189/A/b/c 1 new 100/120 litre bowl chopper serial no.89202 12 new ice flaker 1 new vacum filler/linker with clipper 6 new 200 litre stainless steel trollies 2 new stainless steel tables 1 new waterproof aic electronic scale 6 new stainless steel handwash basins 2 new boot washers 6 new stainless steel transport racks 12 new electric fly killers 2 new handpallet trucks 1 new steamboiler.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust LTD
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1990Registrierung einer Belastung (402 NI)
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 13. Sept. 1989
    Geliefert am 20. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Mortgage all and singular the chattels, plant, machinery and items described or refer- red to the schedule hereto one new stainless steel bacon slicing machine serial no. 3189112 one new aic waterproof electronic scale serial no. A/c 1189 one new muvero cooking cabinet serial no 258938 one new large tumbler 2000 litre injectstar serial no 20089 one new waterproof aic electronic scale serial no. A/c 11689 two new 598 stainless steel ham moulds one new high pressure cleaning system serial no 89117.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust LTD
    Transaktionen
    • 20. Sept. 1989Registrierung einer Belastung (402 NI)
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 16. Apr. 1989
    Geliefert am 18. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies debenture see doc 23 for details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Bank
    Transaktionen
    • 18. Apr. 1989Registrierung einer Belastung (402 NI)
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 29. Juni 1988
    Geliefert am 30. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Chattels mortgage all and singular the chattels, plant, machinery and items described or refer- red to in the schedule hereto:- one - new hoegger bacon press together with ancillary equipment serial no: CH9230FLAWILSG.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust LTD
    Transaktionen
    • 30. Juni 1988Registrierung einer Belastung (402 NI)
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 13. Dez. 1985
    Geliefert am 17. Dez. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Debenture 1) a fixed charge over: all the book debts now and from time to time due or owing to the company but so that the company shall pay into the company's account with the bank all moneys which it may receive in respect of such debts and shall not without the prior consent in writing of the bank sell factor discount or otherwise charge or assign the same in favour of any other person or purport to do so and the company shall if called upon to do so by the bank from time to time execute legal assignments of such book debts and other debts to the bank. 2) a floating charge over: all the under taking of the company and all its pro- perty and assets for the time being both present and future including its good- will and uncalled capital but so that the company shall not without the con- sent in writing of the bank create any mortgage or charge ranking in priority to or pari passu with this debenture.
    Berechtigte Personen
    • Ulster Bank LTD
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1985Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 06. Sept. 1985
    Geliefert am 09. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Debenture all the book debts of frontier meats LTD both present and future the company shall not be at liberty to create any mortgage or charge on any of its book debts ranking in priority to or pari passu with this debenture.
    Berechtigte Personen
    • Ulster Factors LTD
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1985Registrierung einer Belastung (402 NI)
    • 04. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat MOURNE COUNTRY MEATS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Okt. 2014Aufgelöst am
    11. März 2011Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Liz Mckeown
    3 Wellington Park
    Malone Road
    BT9 6DJ Belfast
    Praktiker
    3 Wellington Park
    Malone Road
    BT9 6DJ Belfast

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0